Pauline KUNEMUND

Pauline KUNEMUND

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Pauline KUNEMUND [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1896 New York nach diesem Ort suchen [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Tod 24. Februar 1959 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen Januar 1915 New York, New York, New York, United States nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1920 Bronx Assembly District 1, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen Januar 1925 New York, Bronx, New York, United States nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1930 Bronx, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 New York, Bronx, New York nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 New York, Bronx, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Heirat 18. November 1915 New York City, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
18. November 1915
New York City, New York, USA
Frederick C PASSE

Quellenangaben

1 C:\Users\Marion\Documents\Stammbaum\Sicherungen\Ludwig_Verwandschaft.ged
Kurztitel: Ludwig_Verwandschaft.ged
2 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 16; Assembly District: 18; City: New York; County: New York; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1915
3 New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Bronx
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1130; Page: 4A; Enumeration District: 59
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1920 United States Federal Census
5 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Roll: 1485; Page: 16B; Enumeration District: 0577; FHL microfilm: 2341220
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
Kurztitel: 1930 United States Federal Census
7 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: T627_2497; Page: 14A; Enumeration District: 3-1431
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1940 United States Federal Census
8 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 12; Assembly District: 08; City: New York; County: Bronx; Page: 29
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1925
9 New York, New York, Death Index, 1949-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, New York, Death Index, 1949-1965
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 16; Assembly District: 18; City: New York; County: New York; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1915
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1130; Page: 4A; Enumeration District: 59
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1920 United States Federal Census
12 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Roll: 1485; Page: 16B; Enumeration District: 0577; FHL microfilm: 2341220
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
Kurztitel: 1930 United States Federal Census
13 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: T627_2497; Page: 14A; Enumeration District: 3-1431
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1940 United States Federal Census
14 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 12; Assembly District: 08; City: New York; County: Bronx; Page: 29
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1925
15 New York, New York, Death Index, 1949-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, New York, Death Index, 1949-1965
16 New York, New York, Death Index, 1949-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, New York, Death Index, 1949-1965
17 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 16; Assembly District: 18; City: New York; County: New York; Page: 25
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1915
18 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1130; Page: 4A; Enumeration District: 59
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1920 United States Federal Census
19 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 12; Assembly District: 08; City: New York; County: Bronx; Page: 29
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, State Census, 1925
20 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Bronx, Bronx, New York; Roll: 1485; Page: 16B; Enumeration District: 0577; FHL microfilm: 2341220
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
Kurztitel: 1930 United States Federal Census
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: T627_2497; Page: 14A; Enumeration District: 3-1431
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1940 United States Federal Census
22 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New York, Bronx, New York; Roll: T627_2497; Page: 14A; Enumeration District: 3-1431
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: 1940 United States Federal Census
23 New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Bronx
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995
24 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
Kurztitel: New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937

Datenbank

Titel Baeger
Beschreibung
Hochgeladen 2018-12-26 09:26:55.0
Einsender user's avatar Marion Höckelmann
E-Mail marionhoeck@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person