Eleanor A KNEBEL

Eleanor A KNEBEL

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Eleanor A KNEBEL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 24. Oktober 1917 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Bestattung Pultneyville, Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Tod 6. Dezember 2006 Pultneyville, Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [24] [25] [26] [27]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Robert Llewyln ABSON

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1920;Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 8A; Enumeration District: 248; Image: 835
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 30
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 8A; Enumeration District: 248; Image: 839
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
12 U.S., Obituary Collection, 1930-2017, Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/show/Eleanor-Abson-79139636
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 1920;Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 8A; Enumeration District: 248; Image: 835
17 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 30
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 8A; Enumeration District: 248; Image: 839
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York State, Birth Index, 1881-1942, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Birth Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
22 U.S., Obituary Collection, 1930-2017, Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/show/Eleanor-Abson-79139636
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
23 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 U.S., Obituary Collection, 1930-2017, Publication Place: City, New York, USA; URL: http://www.tributes.com/show/Eleanor-Abson-79139636
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
28 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 30
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 12A; Enumeration District: 65-319
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 3B; Enumeration District: 0172; Image: 707.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 8A; Enumeration District: 248; Image: 839
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person