Ray Willard HALSTEAD

Ray Willard HALSTEAD

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ray Willard HALSTEAD [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 7. Juni 1899 Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Tod 31. Januar 1974 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1920 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17]
Wohnen Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1905 Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1900 Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1940 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1935 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Heirat 11. Juli 1936 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Juli 1936
Lockport, Niagara, New York, USA
Alice Amonica RYAN

Quellenangaben

1 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
2 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
3 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Page: 1; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1241130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
4 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-05-1626; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
5 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 01 E.D. 03; City: Royalton; County: Niagara; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 5, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 10A; Enumeration District: 85
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Niagara; Roll: 1818601; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
8 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
9 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
10 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Page: 1; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1241130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
11 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-05-1626; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
12 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 01 E.D. 03; City: Royalton; County: Niagara; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 5, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 10A; Enumeration District: 85
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
14 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Niagara; Roll: 1818601; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-05-1626; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
16 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 5, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 10A; Enumeration District: 85
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
17 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
18 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Niagara; Roll: 1818601; Draft Board: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
19 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 01 E.D. 03; City: Royalton; County: Niagara; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
20 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Page: 1; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1241130
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
23 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person