Alice Amonica RYAN

Alice Amonica RYAN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Alice Amonica RYAN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Dezember 1909 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Tod 29. August 2002 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1930 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1. Juni 1915 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1920 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1935 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1940 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1910 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Heirat 11. Juli 1936 Lockport, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Juli 1936
Lockport, Niagara, New York, USA
Ray Willard HALSTEAD

Quellenangaben

1 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: T624_1049; Page: 5B; Enumeration District: 0091; FHL microfilm: 1375062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
2 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Lockport Ward 02; County: Niagara; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
3 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
4 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 2, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 7B; Enumeration District: 78
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
5 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-03-7058; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
6 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2341351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: T624_1049; Page: 5B; Enumeration District: 0091; FHL microfilm: 1375062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
9 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Lockport Ward 02; County: Niagara; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
10 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
11 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 2, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 7B; Enumeration District: 78
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
12 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-03-7058; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
13 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
14 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2341351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 078-03-7058; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
16 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 2341351
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
17 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Lockport Ward 02; County: Niagara; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
19 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Lockport Ward 2, Niagara, New York; Roll: T625_1241; Page: 7B; Enumeration District: 78
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
20 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: m-t0627-02695; Page: 15B; Enumeration District: 32-27
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
22 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Lockport, Niagara, New York; Roll: T624_1049; Page: 5B; Enumeration District: 0091; FHL microfilm: 1375062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
23 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person