Lorenzo Solomon GREENE

Lorenzo Solomon GREENE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Lorenzo Solomon GREENE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. Januar 1857 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
Bestattung Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [40] [41]
Tod 7. August 1937 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [42] [43] [44]
Wohnen 1865 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [45] [46]
Wohnen 1920 Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1875 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [48] [49]
Wohnen 1905 Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [50] [51]
Wohnen 1. Juni 1925 Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Wohnen 1860 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]
Wohnen 1892 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [54]
Wohnen Akron, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [55]
Wohnen 1870 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [56]
Wohnen 1880 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [57]
Wohnen 1930 McDonough, Chenango, New York, USA nach diesem Ort suchen [58]
Wohnen 1900 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [59]
Wohnen 1910 Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [60]
Heirat 6. Juli 1879 [61]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
6. Juli 1879
Mary Jane MCMULLEN

Quellenangaben

1 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 460B; Image: 231; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 334; Image: 73; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
20 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
21 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
22 Illinois, County Marriage Records, 1800-1940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
23 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 460B; Image: 231; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 334; Image: 73; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
39 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
40 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
42 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
44 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
45 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
46 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
47 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
48 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Lancaster Thru West Seneca
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
50 New York State Censuses, 1880, 1892, 1905
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
51 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
52 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
53 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M653_750; Page: 334; Image: 73; Family History Library Film: 803750
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
54 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
55 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 460B; Image: 231; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
56 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 460B; Image: 231; Family History Library Film: 552430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
57 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
58 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
59 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
60 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
61 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person