Mary Jane MCMULLEN

Mary Jane MCMULLEN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Mary Jane MCMULLEN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 5. November 1861 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
Bestattung Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [34] [35]
Tod 6. März 1948 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37]
Wohnen 1865 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [38] [39]
Wohnen 1905 Shelby, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1. Juni 1925 Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Royalton, Niagara, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1920 Smithfield, Madison, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1. Juni 1875 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1900 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1930 McDonough, Chenango, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1880 Newstead, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1935 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1. April 1940 Medina, Orleans, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Heirat 6. Juli 1879 [50]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
6. Juli 1879
Lorenzo Solomon GREENE

Notizen zu dieser Person

1870 USA Federal Census Lawrance McMillin Newstead, Erie, NY abt 1828 New York White Male Wor ks on Farm Olive McMillin Newstead, Erie, NY abt 1840 New York White Female May J McMillin Newstead, Erie, NY abt 1862 New York White Female William H McMillin Newstead, Erie, NY abt 1863 New York White Male Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Rol l: M593_931; Page: 465; Image: 237.

Quellenangaben

1 Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 465; Image: 237
2 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
16 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
17 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
18 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
19 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
20 Source Citation: Year: 1870; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: M593_931; Page: 465; Image: 237
21 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
34 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
36 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
38 New York, Erie Census 1855, 1865, 1875, Evans Thru Lancaster
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 New York, State Census, 1865
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Shelby; : Orleans
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Smithville; : Chenango; Page: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Royalton, Niagara, New York; Roll: T624_1050; Page: 2B; Enumeration District: 0134; FHL microfilm: 1375063
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
43 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Smithville, Chenango, New York
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
44 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
46 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Mcdonough, Chenango, New York; Roll: 1416; Page: 3B; Enumeration District: 14; Image: 118.0; FHL microfilm: 2341151
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
47 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 827; Family History Film: 1254827; Page: 100C; Enumeration District: 101; Image: 0387
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
48 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
49 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Medina, Orleans, New York; Roll: T627_2713; Page: 8A; Enumeration District: 37-23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
50 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Newstead, Erie, New York; Roll: 1034; Page: 6B; Enumeration District: 0253; FHL microfilm: 1241034
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person