Walter George ABNER

Walter George ABNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Walter George ABNER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1. Mai 1889 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Bestattung Manchester, Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22]
Tod 24. September 1947 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [23] [24] [25]
Wohnen 1935 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1. April 1940 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen [30]
Wohnen 1930 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1910 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1920 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1900 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

NORA

Quellenangaben

1 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person