Walter George ABNER
♂ Walter George ABNER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Walter George ABNER | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 1. Mai 1889 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] |
Bestattung | Manchester, Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [22] | |
Tod | 24. September 1947 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [23] [24] [25] |
Wohnen | 1935 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [26] |
Wohnen | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [27] | |
Wohnen | 1. April 1940 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [28] |
Wohnen | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [29] | |
Wohnen | [30] | ||
Wohnen | 1930 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [31] |
Wohnen | 1910 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [32] |
Wohnen | 1920 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [33] |
Wohnen | 1900 | Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [34] |
Eltern
Levi ABNER | Rachel ALLEN |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
NORA |
|
Quellenangaben
1 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
2 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
3 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
4 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
5 | Kentucky Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
6 | U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
7 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
8 | U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
9 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
10 | Kentucky, Death Records, 1852-1953 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
11 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
12 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
13 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
14 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
15 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
16 | Kentucky Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
17 | U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
18 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
19 | U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
20 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
21 | Kentucky, Death Records, 1852-1953 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
22 | U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
23 | Kentucky Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
24 | U.S., Headstone Applications for Military Veterans, 1925-1963 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
25 | Kentucky, Death Records, 1852-1953 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
26 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
27 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration : Clay; Roll: 1653348 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
28 | 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Clay, Kentucky; Roll: T627_1296; Page: 8B; Enumeration District: 26-10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
29 | U.S., WWI Civilian Draft Registrations, 1917-1918 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
30 | Kentucky Death Index, 1911-2000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
31 | 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 5, Clay, Kentucky; Roll: 741; Page: 7A; Enumeration District: 0011; Image: 240.0; FHL microfilm: 2340476 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
32 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
33 | 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
34 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
Datenbank
Titel | Family Grimes Stammbaum |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-30 07:34:24.0 |
Einsender | Michael Grimes |
oneofmanyangels@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |