Levi ABNER

Levi ABNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Levi ABNER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 22. Juni 1842 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Tod 4. Dezember 1924 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [18] [19]
Wohnen 1910 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [20] [21]
Wohnen 1920 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1880 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1900 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24]
Heirat 17. Januar 1867 Clay, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [25] [26] [27]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
17. Januar 1867
Clay, Kentucky, USA
Rachel ALLEN

Quellenangaben

1 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bull Skin, Clay, Kentucky
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 Kentucky 1910 Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 Kentucky Marriages, 1851-1900
Autor: Dodd, Jordan, comp
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
10 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 International Genealogical Index(R), downloaded 23 May 2009
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
13 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bull Skin, Clay, Kentucky
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 Kentucky 1910 Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 Kentucky 1910 Miracode Index
Autor: National Archives and Records Administration
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T624_471; Page: 1A; Enumeration District: 0050; FHL microfilm: 1374484
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: T625_566; Page: 4A; Enumeration District: 41; Image: 190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bull Skin, Clay, Kentucky
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Allen, Clay, Kentucky; Roll: 516; Page: 10B; Enumeration District: 0030; FHL microfilm: 1240516
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 Kentucky Marriages, 1851-1900
Autor: Dodd, Jordan, comp
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 International Genealogical Index(R), downloaded 13 Aug 2008
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person