Lloyd Frank GRAU

Lloyd Frank GRAU

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Lloyd Frank GRAU [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Januar 1899 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [17]
Tod 18. Dezember 1953 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18] [19]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1931 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Heirat 26. Juli 1919 Irondequoit, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
26. Juli 1919
Irondequoit, Monroe, New York, USA
Loretta Elizabeth SCHICKER

Quellenangaben

1 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 9A; Enumeration District: 0017; Image: 61.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-369
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
8 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
9 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index; Certificate Number: 77724
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
10 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
11 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
12 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 9A; Enumeration District: 0017; Image: 61.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-369
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
16 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index; Certificate Number: 77724
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
18 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index; Certificate Number: 77724
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
19 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
20 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-369
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration : Monroe; Roll: 1818805; Draft Board: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4B; Enumeration District: 65-369
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 9A; Enumeration District: 0017; Image: 61.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
27 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
28 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
29 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person