Fred Henry LINTKER

Fred Henry LINTKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Fred Henry LINTKER [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 24. Dezember 1872 Germany nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25]
Bestattung 1930 Saint Stephen Cemetery, Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [26]
Tod 10. Dezember 1930 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [27] [28] [29]
Wohnen 1900 Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1920 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Arrival 1890 [35] [36]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0009; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 22, Hamilton, Ohio; Roll: 1278; Page: 10; Enumeration District: 0182; FHL microfilm: 1241278
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 19 Oct 1969; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100872212/?article=22293f97-c227-4b15-bc79-81a49caf56ef&focus=0.46109903,0.7800413,0.5674982,0.8383667&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0009; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 22, Hamilton, Ohio; Roll: 1278; Page: 10; Enumeration District: 0182; FHL microfilm: 1241278
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Cincinnati Enquirer; Publication Date: 19 Oct 1969; Publication Place: Cincinnati, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/100872212/?article=22293f97-c227-4b15-bc79-81a49caf56ef&focus=0.46109903,0.7800413,0.5674982,0.8383667&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0009; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 22, Hamilton, Ohio; Roll: 1278; Page: 10; Enumeration District: 0182; FHL microfilm: 1241278
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Kentucky, U.S., Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 22, Hamilton, Ohio; Roll: 1278; Page: 10; Enumeration District: 0182; FHL microfilm: 1241278
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: Kentucky; Registration County: Campbell
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0009; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Page: 1B; Enumeration District: 0009; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cincinnati Ward 22, Hamilton, Ohio; Roll: 1278; Page: 10; Enumeration District: 0182; FHL microfilm: 1241278
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person