Fred B. PHILLIPS

Fred B. PHILLIPS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Fred B. PHILLIPS [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt etwa 1872 Wolcott, Wayne County, New York nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Tod 1955 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "8 Sept 1955") Huron, Wayne County, New York nach diesem Ort suchen
Wohnen 1910 Utica Ward 3, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1929 Utica, New York, USA nach diesem Ort suchen [19] [20]
Wohnen 1909 Utica, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. Juni 1925 Huron, Wayne, New York, United States nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1892 Wolcott, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1930 Huron, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1920 Huron, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1880 Wolcott, Wayne, New York, United States nach diesem Ort suchen [26]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Emma M. WOOD

Quellenangaben

1 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 525.2000; Enumeration District: 194; Image: 0752.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: T625_1273; Page: 4A; Enumeration District: 142; Image: 898.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 3B; Enumeration District: 16; Image: 208.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Huron; County: Wayne; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 02; City: Utica Ward 15; County: Oneida; Page: 06
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 3, Oneida, New York; Roll: T624_1052; Page: 6B; Enumeration District: 0108; FHL microfilm: 1375065
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 525.2000; Enumeration District: 194; Image: 0752.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: T625_1273; Page: 4A; Enumeration District: 142; Image: 898.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 3B; Enumeration District: 16; Image: 208.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Huron; County: Wayne; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 02; City: Utica Ward 15; County: Oneida; Page: 06
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 3, Oneida, New York; Roll: T624_1052; Page: 6B; Enumeration District: 0108; FHL microfilm: 1375065
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Utica Ward 3, Oneida, New York; Roll: T624_1052; Page: 6B; Enumeration District: 0108; FHL microfilm: 1375065
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Huron; County: Wayne; Page: 17
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: 1658; Page: 3B; Enumeration District: 16; Image: 208.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Huron, Wayne, New York; Roll: T625_1273; Page: 4A; Enumeration District: 142; Image: 898.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 525.2000; Enumeration District: 194; Image: 0752.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person