Jean JUTTA STEINFELD

Jean JUTTA STEINFELD

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Jean JUTTA STEINFELD [1] [2] [3] [4] [5]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 4. Mai 1920 Berlin nach diesem Ort suchen [6] [7] [8]
Wohnen 1939 Germany nach diesem Ort suchen [9]
Wohnen 1984 McLean, VA nach diesem Ort suchen [10]
Wohnen Mc Lean, VA nach diesem Ort suchen [11]
Departure 1939 Hamburg, Germany nach diesem Ort suchen [12]
Arrival 9. Februar 1939 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14]
NaturalizationDeclaration 17. Juli 1939 New York nach diesem Ort suchen [15]
Heirat 10. Februar 1950 New York City, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
10. Februar 1950
New York City, New York, USA
Rudolf Georg LACHMANN-MOSSE

Quellenangaben

1 Virginia, Death Records, 1912-2014, Virginia Department of Health; Richmond, Virginia; Virginia Deaths, 1912-2014
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 7; Page Number: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
6 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 7; Page Number: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
9 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 7; Page Number: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
10 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 7; Page Number: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
13 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1939; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 7; Page Number: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.Ursprüngliche Daten - Passenger Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1820-1897; (National Archives Microfilm Publication M237, 675 rolls); Records of the U.S. Customs
15 New York, Naturalization Petitions, 1794-1906, The National Archives at Philadelphia; Philadelphia, Pennsylvania; NAI Title: Declarations of Intention for Citizenship, 1/19/1842 - 10/29/1959; NAI Number: 4713410; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Re
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 5
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Weule-Woile-Datenbank 2022
Beschreibung
Hochgeladen 2022-02-13 20:53:23.0
Einsender user's avatar Reinhard Weule
E-Mail reinhard.weule@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person