Ellen Augusta STEPHENS

Ellen Augusta STEPHENS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ellen Augusta STEPHENS [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 14. Juni 1857 Mangotsfield, St James, Gloucestershire, England nach diesem Ort suchen [29]
Geburt 7. April 1857 Staple, Bristol, Gloucestershire, England nach diesem Ort suchen [30] [31] [32] [33] [34]
Bestattung 1941 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [35]
Tod 12. Juli 1941 Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [36] [37]
Wohnen 1861 Mangotsfield, Gloucestershire, England nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1871 Coleford, Newland All Saints, Gloucestershire, England nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1880 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1900 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1925 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1927 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1930 Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1935 Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1940 Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [47]
Arrival 1872 [48] [49] [50]
Arrival 9. September 1925 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Departure vor 9. September 1925 Southampton, Hampshire, England nach diesem Ort suchen [52]
Heirat 11. Oktober 1876 Cuyahoga, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [53] [54] [55] [56]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
11. Oktober 1876
Cuyahoga, Ohio, USA
John BARCLAY

Quellenangaben

1 Cuyahoga, Ohio, U.S., Marriage Records and Indexes, 1810-1973, Cuyahoga County Archive; Cleveland, Ohio; Cuyahoga, Ohio, Marriage Records, 1810-1973; Volume: Vol 19-20; Page: 336; Year Range: 1875 Apr - 1877 Aug
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Roll: m-t0627-03050; Page: 61A; Enumeration District: 18-73
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, PA; Pennsylvania (State). Death Certificates, 1906-1968; Box Number: 2429; Certificate Number Range: 034501-037500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Page: 5A; Enumeration District: 0581; FHL microfilm: 2341518
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Roll: 1008; Page: 188D; Enumeration District: 048
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1925; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 5; Page Number: 121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1871 England Census, The National Archives; Kew, London, England; 1871 England Census; Class: RG10; Piece: 5298; Folio: 61; Page: 10; GSU roll: 848430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cleveland Ward 26, Cuyahoga, Ohio; Roll: T624_1176; Page: 4A; Enumeration District: 0386; FHL microfilm: 1375189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1861 England Census, Class: RG 9; Piece: 1699; Folio: 23; Page: 1; GSU roll: 542853
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Bristol, England, Select Church of England Parish Registers, 1720-1933
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Presbyterian Church Records, 1701-1970, Presbyterian Historical Society; Philadelphia, Pennsylvania; U.s., Presbyterian Church Records, 1701-1907; Book Title: 1870-1889
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Harrisburg, PA; Pennsylvania (State). Death Certificates, 1906-1968; Box Number: 2429; Certificate Number Range: 034501-037500
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Page: 5A; Enumeration District: 0581; FHL microfilm: 2341518
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cleveland Ward 26, Cuyahoga, Ohio; Roll: T624_1176; Page: 4A; Enumeration District: 0386; FHL microfilm: 1375189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Bristol, England, Select Church of England Parish Registers, 1720-1933
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Page: 5A; Enumeration District: 0581; FHL microfilm: 2341518
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1871 England Census, The National Archives; Kew, London, England; 1871 England Census; Class: RG10; Piece: 5298; Folio: 61; Page: 10; GSU roll: 848430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cleveland Ward 26, Cuyahoga, Ohio; Roll: T624_1176; Page: 4A; Enumeration District: 0386; FHL microfilm: 1375189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 1861 England Census, Class: RG 9; Piece: 1699; Folio: 23; Page: 1; GSU roll: 542853
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 1871 England Census, The National Archives; Kew, London, England; 1871 England Census; Class: RG10; Piece: 5298; Folio: 61; Page: 10; GSU roll: 848430
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Roll: 1008; Page: 188D; Enumeration District: 048
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cleveland Ward 26, Cuyahoga, Ohio; Roll: T624_1176; Page: 4A; Enumeration District: 0386; FHL microfilm: 1375189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Page: 5A; Enumeration District: 0581; FHL microfilm: 2341518
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
46 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Roll: m-t0627-03050; Page: 61A; Enumeration District: 18-73
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
47 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Roll: m-t0627-03050; Page: 61A; Enumeration District: 18-73
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Cleveland Heights, Cuyahoga, Ohio; Page: 5A; Enumeration District: 0581; FHL microfilm: 2341518
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
49 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
50 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Cleveland Ward 26, Cuyahoga, Ohio; Roll: T624_1176; Page: 4A; Enumeration District: 0386; FHL microfilm: 1375189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
51 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1925; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 5; Page Number: 121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1925; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 5; Page Number: 121
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 Cuyahoga, Ohio, U.S., Marriage Records and Indexes, 1810-1973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 Cuyahoga, Ohio, U.S., Marriage Records and Indexes, 1810-1973, Cuyahoga County Archive; Cleveland, Ohio; Cuyahoga, Ohio, Marriage Records, 1810-1973; Volume: Vol 19-20; Page: 336; Year Range: 1875 Apr - 1877 Aug
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
55 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cleveland , Cuyahoga, Ohio; Roll: 1253; Page: 7A; Enumeration District: 0053; FHL microfilm: 1241253
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
56 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person