Jonathan Cashman BEECHER

Jonathan Cashman BEECHER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Jonathan Cashman BEECHER [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Name J. C. BEECHER [12]
Name J. C. BUCHER [13] [14]
Beruf 11. Februar 1895 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. Februar 1818 Mount Pleasant Township, Adams, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Bestattung 17. Februar 1895 Carlisle: Salem Stone Church Cemetery, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [23] [24] [25]
Volkszählung 1850 Frankford Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [26]
Volkszählung 1860 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [27]
Volkszählung 1870 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [28]
Volkszählung 1880 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [29]
Tod 11. Februar 1895 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [30] [31] [32] [33]
Testament 4. April 1893 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [34]
Tax List 1841 Menallen Township, Adams, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen
Newspaper 23. November 1842 Carlisle, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [35]
Tax List 1853 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [36]
Tax List 1868 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [37]
Tax List 1877 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [38]
Newspaper 6. Mai 1881 Shippensburg, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [39]
Property 1894 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [40]
Newspaper 26. Juni 1894 Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [41]
Newspaper 26. Juni 1894 Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [42]
Newspaper 27. Juni 1894 Altoona, Blair, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [43]
Cause of Death 11. Februar 1895 North Middleton Township, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [44]
Death Certificate 27. Mai 1895 , Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [45]
Heirat 17. November 1842 Carlisle, Cumberland, Pennsylvania, United States nach diesem Ort suchen [46] [47]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
17. November 1842
Carlisle, Cumberland, Pennsylvania, United States
Catharine SWIGERT

Quellenangaben

1 Records of Sharon Swope
Angaben zur Veröffentlichung: http://worldconnect.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?db=nickol
Kurztitel: Records of Sharon Swope
2 1870 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1870 United States Census
3 1860 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1860 United States Census
4 Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records collected by Jeremiah Zeamer, Page 36
Autor: McElwain, Wilbur J.
Angaben zur Veröffentlichung: Heritage Books, 1994. Pages: xi, 266 p. ISBN: 0788400754
Kurztitel: Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records
5 The Lineage of Christian Kersheman 1774-1893
Autor: Shull, William F.
Angaben zur Veröffentlichung: 1893. Original copy in possession of Arthur Weaner, 145 Weaner Rd, Gettysburg PA 17325-8118.
Kurztitel: The Lineage of Christian Kersheman 1774-1893
6 Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963, Certificate Number: 116681. George T. Beacher.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Original data: Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1963. Series 11.90 (1,905 cartons). Records of the Pennsylvania Department of Health, Record Group 11. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg, Pennsylvania.
Kurztitel: Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963
7 Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963, Death Certificate 73210. Mary J. B. Gibson. Father Johnatha
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Original data: Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1963. Series 11.90 (1,905 cartons). Records of the Pennsylvania Department of Health, Record Group 11. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg, Pennsylvania.
Kurztitel: Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1963
8 History and genealogy of the German emigrant Johan Christian Kirschenmann, anglicized Cashman, Appendix C, page 74-90.
Autor: Weaner, Arthur
Angaben zur Veröffentlichung: Gettysburg, Pa. :: Priv. print. by A. Weaner,, 1960, 178 pgs. Available online at Heritage Quest.
Kurztitel: History and genealogy of the German emigrant Johan Christian Kirschenmann, anglicized Cashman
9 Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
Angaben zur Veröffentlichung: http://marciasandmeyerwilson.com and emails from Macia S. Wilson
Kurztitel: Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
10 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
11 The Carlisle Herald, 23 Nov 1842
Angaben zur Veröffentlichung: Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
Kurztitel: The Carlisle Herald, Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
12 1880 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1880 United States Census
13 1870 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1870 United States Census
14 1860 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1860 United States Census
15 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
16 1870 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1870 United States Census
17 1860 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1860 United States Census
18 Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records collected by Jeremiah Zeamer, Page 36
Autor: McElwain, Wilbur J.
Angaben zur Veröffentlichung: Heritage Books, 1994. Pages: xi, 266 p. ISBN: 0788400754
Kurztitel: Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records
19 1880 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1880 United States Census
20 Find A Grave, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=51008
Kurztitel: Find A Grave
21 Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
Angaben zur Veröffentlichung: http://marciasandmeyerwilson.com and emails from Macia S. Wilson
Kurztitel: Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
22 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
23 Find A Grave, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=51008
Kurztitel: Find A Grave
24 Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
Angaben zur Veröffentlichung: http://marciasandmeyerwilson.com and emails from Macia S. Wilson
Kurztitel: Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
25 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
26 1850 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, Frankford Township, Series
Kurztitel: 1850 United States Census
27 1860 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1860 United States Census
28 1860 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1860 United States Census
29 1880 United States Census, Pennsylvania, Cumberland County, North Middleton Township
Kurztitel: 1880 United States Census
30 Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records collected by Jeremiah Zeamer, Page 36
Autor: McElwain, Wilbur J.
Angaben zur Veröffentlichung: Heritage Books, 1994. Pages: xi, 266 p. ISBN: 0788400754
Kurztitel: Cumberland County, Pennsylvania, cemetery records
31 Find A Grave, http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=51008
Kurztitel: Find A Grave
32 Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
Angaben zur Veröffentlichung: http://marciasandmeyerwilson.com and emails from Macia S. Wilson
Kurztitel: Research of Marcia S. Wilson, great grandaughter of Mary Jane Beecher Gibson
33 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
34 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Will # 524, Book U page 369, Will of Jonathan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
35 The Carlisle Herald, 23 Nov 1842
Angaben zur Veröffentlichung: Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
Kurztitel: The Carlisle Herald, Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
36 Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
Angaben zur Veröffentlichung: 21 North Pitt St, Carlisle, PA 17013. https://www.historicalsociety.com
Kurztitel: Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
37 Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
Angaben zur Veröffentlichung: 21 North Pitt St, Carlisle, PA 17013. https://www.historicalsociety.com
Kurztitel: Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
38 Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
Angaben zur Veröffentlichung: 21 North Pitt St, Carlisle, PA 17013. https://www.historicalsociety.com
Kurztitel: Cumberland County Historical Society (Carlisle, PA)
39 The Valley Sentinel (Shippensburg, PA), 6 May 1881
Kurztitel: The Valley Sentinel (Shippensburg, PA)
40 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Deed Book 5F Page 291
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
41 Harrisburg Telegraph, 26 Jun 1894, page 1.
Angaben zur Veröffentlichung: Harrisburg Telegraph, Harrisburg, Dauphin, Pennsylvania.
Kurztitel: Harrisburg Telegraph
42 The Patriot (Harrisburg, PA), 26 Jun 1894, page 3.
Kurztitel: The Patriot (Harrisburg, PA)
43 Altoona Tribune, 27 Jun 1894, page 2.
Angaben zur Veröffentlichung: Altoona, Blair, Pennsylvania.
Kurztitel: Altoona Tribune
44 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
45 Cumberland County Courthouse, Cumberland County, Pennsylvania, Death Record #998, Joanthan C. Beecher
Kurztitel: Cumberland County Courthouse
46 The Carlisle Herald, Nov. 23 1842
Angaben zur Veröffentlichung: Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
Kurztitel: The Carlisle Herald, Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
47 The Carlisle Herald, 23 Nov 1842
Angaben zur Veröffentlichung: Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania
Kurztitel: The Carlisle Herald, Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania

Datenbank

Titel Beecher Beacher Bicher Bucher
Beschreibung Ancestors in Pennsylvania, USA whose families immigrated from Europe. The authors family surname is Beacher or Beecher but descended from original surname Bücher.
Hochgeladen 2018-02-18 13:26:15.0
Einsender user's avatar Jonathan Beacher
E-Mail jonathan@searchtrees.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person