* Johann " John " Heinrich Adolph MEINKE

* Johann " John " Heinrich Adolph MEINKE

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name * Johann " John " Heinrich Adolph MEINKE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. August 1876 Weddewarden, Bremerhaven, Bremen, Deutschland ( Land Wursten) nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Tod vor 1940
Wohnen New York nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen New York, New York nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1933 570 E, 136 Street, Bronx, NY nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1931 570 E, 136 Street, Bronx, NY nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. Juni 1915 570 East, 136 Street, Bronx, NY nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1920 570 E, 136 Street, Bronx, NY nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen zu einem Zeitpunkt zwischen 1917 und 1918 570 E, 136 Street, Bronx, NY nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1910 1784, First Ave, Manhattan, NY nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1905 1784, First Ave, Manhattan, NY nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen Juni 1900 1784 First Ave, Manhattan, NY nach diesem Ort suchen [32]
Arrival 1900 [33]
Arrival 28. November 1893 New York, New York nach diesem Ort suchen [34] [35] [36]
Departure Bremen nach diesem Ort suchen [37]
Einbürgerung 29. März 1900 Wohnort: 345 East, 92 Street, NY City nach diesem Ort suchen
Arrival 15. November 1892 [38]
Heirat 1899 [39]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1899
Emma (MEINKE)

Quellenangaben

1 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, 1795-1905; Roll #: 602; Volume #: Roll 602 - 02 Jun 1902-07 Jun 1902
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Mic
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1893; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 621; Line: 2; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Roll: 1154; Page: 28A; Enumeration District: 0831; FHL microfilm: 1241118
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1013; Page: 10A; Enumeration District: 0282; FHL microfilm: 1375026
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1129; Page: 22B; Enumeration District: 10; Image: 560
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753933; Draft Board: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 26; City: Manhattan; County: New York; Page: 45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 New York, Petitions for Naturalization, 1794-1906, National Archives at New York City; US District Court for the Southern District of New York (088-089B); ARC Number: 5324244; ARC Title: Petitions for Naturalization, 1793-1906; Record Group Title: Rec
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 41; Assembly District: 30; City: New York; County: Bronx; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, 1795-1905; Roll #: 602; Volume #: Roll 602 - 02 Jun 1902-07 Jun 1902
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Mic
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1893; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 621; Line: 2; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Roll: 1154; Page: 28A; Enumeration District: 0831; FHL microfilm: 1241118
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1013; Page: 10A; Enumeration District: 0282; FHL microfilm: 1375026
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1129; Page: 22B; Enumeration District: 10; Image: 560
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753933; Draft Board: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 26; City: Manhattan; County: New York; Page: 45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 New York, Petitions for Naturalization, 1794-1906, National Archives at New York City; US District Court for the Southern District of New York (088-089B); ARC Number: 5324244; ARC Title: Petitions for Naturalization, 1793-1906; Record Group Title: Rec
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 41; Assembly District: 30; City: New York; County: Bronx; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Mic
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S. Passport Applications, 1795-1925, National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C.; NARA Series: Passport Applications, 1795-1905; Roll #: 602; Volume #: Roll 602 - 02 Jun 1902-07 Jun 1902
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 41; Assembly District: 30; City: New York; County: Bronx; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1129; Page: 22B; Enumeration District: 10; Image: 560
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration State: New York; Registration County: Bronx; Roll: 1753933; Draft Board: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1013; Page: 10A; Enumeration District: 0282; FHL microfilm: 1375026
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 30 E.D. 26; City: Manhattan; County: New York; Page: 45
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Roll: 1154; Page: 28A; Enumeration District: 0831; FHL microfilm: 1241118
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bronx Assembly District 1, Bronx, New York; Roll: T625_1129; Page: 22B; Enumeration District: 10; Image: 560
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1893; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 621; Line: 2; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Roll: 1154; Page: 28A; Enumeration District: 0831; FHL microfilm: 1241118
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan Ward 12, New York, New York; Roll: T624_1013; Page: 10A; Enumeration District: 0282; FHL microfilm: 1375026
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1893; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 621; Line: 2; Page Number: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 U.S. Naturalization Record Indexes, 1791-1992 (Indexed in World Archives Project), National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Soundex Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906 (M1674); Mic
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Manhattan, New York, New York; Roll: 1154; Page: 28A; Enumeration District: 0831; FHL microfilm: 1241118
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Familie Meinke und Dürels aus Imsum und USA
Beschreibung
Hochgeladen 2018-01-05 20:54:26.0
Einsender user's avatar Sabine Sengstake-Köhler
E-Mail sabine-sengstake-koehler@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person