Elizabeth HORNER

Elizabeth HORNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Elizabeth HORNER [1] [2] [3] [4] [5]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 2. Februar 1864 Pateley Bridge, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [6] [7] [8] [9] [10]
Taufe 8. März 1864 Pateley Bridge, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen
Tod 1957 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "after 1957") Grand Rapids, Kent, Michigan, United States nach diesem Ort suchen
Einwanderung 1880 from England to Grand Rapids, Michigan, United States nach diesem Ort suchen
Wohnen 1878 Pocklington, East Riding, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen
Wohnen 1910 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1930 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1871 Yeadon, Yorkshire, England nach diesem Ort suchen [14]
Arrival 16. August 1880 New York nach diesem Ort suchen [15]
Departure Liverpool, England and Queenstown, Ireland nach diesem Ort suchen [16]

Quellenangaben

1 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Grand Rapids, Kent, Michigan; Roll: 1001; Page: 27A; Enumeration District: 44; Image: 692.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21B; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1871 England Census, Class: RG10; Piece: 4307; Folio: 58; Page: 15; GSU roll: 846978.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1880; Arrival: New York, United States; Microfilm serial: M237; Microfilm roll: M237_429; Line: 36; List number: 1042.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person