Benjamin Bean HORNER

Benjamin Bean HORNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Benjamin Bean HORNER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 13. September 1893 Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Tod 21. Mai 1971 Ojai, Ventura, California, United States of America nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1941 Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1910 Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1900 Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1930 Los Angeles, Los Angeles, California nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1920 Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1918 Indianapolis, Marion, Indiana nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1959 305 N. Foothill Road, Ojai, CA nach diesem Ort suchen
Wohnen Grand Rapids Mich nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1915 Indiana nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1933 Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1934 Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1945 Montecito, California, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1935 Santa Barbara, California nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1. April 1940 Santa Barbara, California, United States nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1948 Ojai, California nach diesem Ort suchen
Arrival 29. November 1926 New York, New York nach diesem Ort suchen [36]
Departure 1926 Southampton, England nach diesem Ort suchen [37]
Heirat 1920 Michigan nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Esther Ruth VANROSSUM
Heirat Ehepartner Kinder
1920
Michigan
Adelaide Lena

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., School Catalogs, 1765-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., School Catalogs, 1765-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S., School Catalogs, 1765-1935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person