Benjamin Bean HORNER
♂ Benjamin Bean HORNER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Benjamin Bean HORNER | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 13. September 1893 | Grand Rapids, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] |
Tod | 21. Mai 1971 | Ojai, Ventura, California, United States of America nach diesem Ort suchen | [22] |
Wohnen | 1941 | Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen | [23] |
Wohnen | 1910 | Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana nach diesem Ort suchen | [24] |
Wohnen | 1900 | Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan nach diesem Ort suchen | [25] |
Wohnen | 1930 | Los Angeles, Los Angeles, California nach diesem Ort suchen | [26] |
Wohnen | 1920 | Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California nach diesem Ort suchen | [27] |
Wohnen | 1918 | Indianapolis, Marion, Indiana nach diesem Ort suchen | [28] |
Wohnen | 1959 | 305 N. Foothill Road, Ojai, CA nach diesem Ort suchen | |
Wohnen | Grand Rapids Mich nach diesem Ort suchen | [29] | |
Wohnen | 1915 | Indiana nach diesem Ort suchen | [30] |
Wohnen | 1933 | Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen | [31] |
Wohnen | 1934 | Santa Barbara, California, USA nach diesem Ort suchen | [32] |
Wohnen | 1945 | Montecito, California, USA nach diesem Ort suchen | [33] |
Wohnen | 1935 | Santa Barbara, California nach diesem Ort suchen | [34] |
Wohnen | 1. April 1940 | Santa Barbara, California, United States nach diesem Ort suchen | [35] |
Wohnen | 1948 | Ojai, California nach diesem Ort suchen | |
Arrival | 29. November 1926 | New York, New York nach diesem Ort suchen | [36] |
Departure | 1926 | Southampton, England nach diesem Ort suchen | [37] |
Heirat | 1920 | Michigan nach diesem Ort suchen |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
Esther Ruth VANROSSUM |
|
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
1920 Michigan |
Adelaide Lena |
|
Quellenangaben
1 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
2 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
8 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
10 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
11 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
13 | U.S., School Catalogs, 1765-1935 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
15 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
17 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
18 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
20 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
21 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
22 | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 564-26-3153; Issue State: California; Issue Date: Before 1951. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
23 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
24 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Indianapolis Ward 2, Marion, Indiana; Roll: T624_366; Page: 5A; Enumeration District: 53; Image: 919. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
25 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Grand Rapids Ward 4, Kent, Michigan; Roll: T623 722; Page: 21A; Enumeration District: 58. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
26 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Los Angeles, Los Angeles, California; Roll: 134; Page: 22B; Enumeration District: 64; Image: 416.0. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
27 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Los Angeles Assembly District 63, Los Angeles, California; Roll: T625_106; Page: 16B; Enumeration District: 163; Image: 749. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
28 | U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: Marion County, Indiana; Roll: 1504015; Draft Board: 2. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
29 | U.S., School Catalogs, 1765-1935 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
30 | U.S., School Catalogs, 1765-1935 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
31 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
32 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
33 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
34 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
35 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Santa Barbara, California; Roll: T627_333; Page: 6A; Enumeration District: 42-2 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
36 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
37 | New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1926; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_3971; Line: ; List number: . Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Horner Kaftan family tree |
Beschreibung | Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer |
Hochgeladen | 2018-04-15 14:28:39.0 |
Einsender | Laura K. |
laamka@yahoo.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |