Clayton I. PHILLIPS

Clayton I. PHILLIPS

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Clayton I. PHILLIPS [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 20. März 1872 Wolcott, Wayne County, New York nach diesem Ort suchen [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Bestattung Wayne County, New York, USA nach diesem Ort suchen [16]
Tod 24. März 1928 Rose, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1. Juni 1915 Rose, Wayne, New York, United States nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1900 Rose, Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1. Juni 1925 Rose, Wayne, New York, United States nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1920 Rose, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1910 Rose, Wayne, New York nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1880 Wolcott, Wayne, New York, United States nach diesem Ort suchen [23]
Heirat 24. September 1896 [24]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
24. September 1896
Rena E JONES

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 540.1000; Enumeration District: 194; Image: 0781.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T624_1094; Page: 3A; Enumeration District: 154; Image: 778.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T625_1274; Page: 2B; Enumeration District: 158; Image: 164.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, State Census, 1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1915
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: 1173; Page: 4A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1241173
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 540.1000; Enumeration District: 194; Image: 0781.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T624_1094; Page: 3A; Enumeration District: 154; Image: 778.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T625_1274; Page: 2B; Enumeration District: 158; Image: 164.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York, State Census, 1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 New York, State Census, 1915
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: 1173; Page: 4A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1241173
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Web: New York, Find A Grave Index, 1660-2012
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, State Census, 1915
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: 1173; Page: 4A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1241173
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 New York, State Census, 1925
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T625_1274; Page: 2B; Enumeration District: 158; Image: 164.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: T624_1094; Page: 3A; Enumeration District: 154; Image: 778.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Wolcott, Wayne, New York; Roll: T9_944; Family History Film: 1254944; Page: 540.1000; Enumeration District: 194; Image: 0781.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rose, Wayne, New York; Roll: 1173; Page: 4A; Enumeration District: 0122; FHL microfilm: 1241173
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person