Roland S. KNOWLSON

Roland S. KNOWLSON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Roland S. KNOWLSON [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 2. Januar 1893 Peekskill, Westchester County, New York nach diesem Ort suchen [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Tod 1957
Wohnen 1900 Cortlandt, Westchester, New York nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1930 Kansas City, Jackson, Missouri nach diesem Ort suchen [14]
Wohnen 1918 Manhattan, New York, New York nach diesem Ort suchen [15]
Wohnen 1920 Dallas Precinct 1, Dallas, Texas nach diesem Ort suchen [16]
Wohnen 1920 Manhattan Assembly District 23, New York, New York nach diesem Ort suchen [17]
Arrival 9. Oktober 1914 New York, New York nach diesem Ort suchen [18]
Departure Colon,R. P. nach diesem Ort suchen [19]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Stella S.

Quellenangaben

1 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2376; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cortlandt, Westchester, New York; Roll: T623 1174; Page: 5B; Enumeration District: 61.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kansas City, Jackson, Missouri; Roll: 1204; Page: 57A; Enumeration District: 241; Image: 326.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: New York County, New York; Roll: 1786806; Draft Board: 147.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Manhattan Assembly District 23, New York, New York; Roll: T625_1226; Page: 10B; Enumeration District: 1489; Image: 694.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Dallas Precinct 1, Dallas, Texas; Roll: T625_1791; Page: 8A; Enumeration District: 5; Image: 200.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2376; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cortlandt, Westchester, New York; Roll: T623 1174; Page: 5B; Enumeration District: 61.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kansas City, Jackson, Missouri; Roll: 1204; Page: 57A; Enumeration District: 241; Image: 326.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: New York County, New York; Roll: 1786806; Draft Board: 147.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Manhattan Assembly District 23, New York, New York; Roll: T625_1226; Page: 10B; Enumeration District: 1489; Image: 694.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Dallas Precinct 1, Dallas, Texas; Roll: T625_1791; Page: 8A; Enumeration District: 5; Image: 200.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Cortlandt, Westchester, New York; Roll: T623 1174; Page: 5B; Enumeration District: 61.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Kansas City, Jackson, Missouri; Roll: 1204; Page: 57A; Enumeration District: 241; Image: 326.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918, Registration Location: New York County, New York; Roll: 1786806; Draft Board: 147.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Dallas Precinct 1, Dallas, Texas; Roll: T625_1791; Page: 8A; Enumeration District: 5; Image: 200.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Manhattan Assembly District 23, New York, New York; Roll: T625_1226; Page: 10B; Enumeration District: 1489; Image: 694.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2376; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1914; Arrival: , ; Microfilm serial: T715; Microfilm roll: T715_2376; Line: ; List number: .
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Horner Kaftan family tree
Beschreibung Family names Horner, Weise, Findeisn, Maier, Holtzknecht, Kaftan, Cach, Wysuph, Cherney, Blatterbauer, Stary, Linke, Laufer
Hochgeladen 2018-04-15 14:28:39.0
Einsender user's avatar Laura K.
E-Mail laamka@yahoo.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person