Helen Lillian KENNEDY

Helen Lillian KENNEDY

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Helen Lillian KENNEDY [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 30. November 1899 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Tod 10. Juni 1971 Los Angeles, Los Angeles, California, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1915 New Hartford, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1949 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1952 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1952 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1952 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1910 Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1900 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Heirat 2. Januar 1917 Utica, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [41] [42] [43] [44]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

William L CLAY
Heirat Ehepartner Kinder
2. Januar 1917
Utica, Oneida, New York, USA
Frank Anthony SCHIMMEL

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 05; Assembly District: 02; City: New Hartford; : Oneida; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 Source
3 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 136; Page: 15A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1240136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 3, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 1B; Enumeration District: 0165; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 California, Death Index, 1940-1997, Date: 1971-06-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 Donnalee Priddle
7 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
10 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 4B; Enumeration District: 164
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
11 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
12 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
13 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
14 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
15 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02846; Page: 7A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
16 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
17 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 05; Assembly District: 02; City: New Hartford; : Oneida; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 Source
19 Wayne Grimes
20 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 136; Page: 15A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1240136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 3, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 1B; Enumeration District: 0165; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 California, Death Index, 1940-1997, Date: 1971-06-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 4B; Enumeration District: 164
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
24 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
25 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
26 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
27 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02846; Page: 7A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
28 California, Death Index, 1940-1997, Date: 1971-06-10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 05; Assembly District: 02; City: New Hartford; : Oneida; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 3, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 1B; Enumeration District: 0165; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 136; Page: 15A; Enumeration District: 0139; FHL microfilm: 1240136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
36 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02846; Page: 7A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
37 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02846; Page: 7A; Enumeration District: 65-174
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
38 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; County: Monroe; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
39 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2002;
40 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 4B; Enumeration District: 164
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
41 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
42 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
43 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
44 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person