Anna M. HILLER

Anna M. HILLER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Anna M. HILLER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 20. Februar 1899 New York, USA nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Bestattung 24. Juni 1986 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Tod 21. Juni 1986 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Ethnicity/Relig. [35]
Heirat 18. Juni 1919 Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
18. Juni 1919
Monroe, New York, USA
John Michael SCHICKER

Quellenangaben

1 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-358
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 7B; Enumeration District: 0188; Image: 410.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
6 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 110-16-3606; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 7A; Enumeration District: 261
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
14 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-358
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 7B; Enumeration District: 0188; Image: 410.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
19 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 110-16-3606; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
21 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 7A; Enumeration District: 261
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
22 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
23 Holy Sepulchre Cemetery Record, Online Grave Listing
Autor: Holy Sepulchre Cemetery
24 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 110-16-3606; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 7A; Enumeration District: 261
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
26 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 07; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 18, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0179; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 7B; Enumeration District: 0188; Image: 410.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-358
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 8A; Enumeration District: 65-358
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 Golden Jubilee Souvenir Book, Holy Redeemer Church, 1917, from Rundel Library,Rochester NY
36 Most Holy Redeemer Baptisms (1867-1918), Roll 6, Item 12, Diocese of Rochester records at Nazareth College Library, 1889, #49
37 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
38 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person