Ervin Lyman FURREY

Ervin Lyman FURREY

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ervin Lyman FURREY [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Religionszugehörigkeit

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 22. Februar 1851 Norwich, New London, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Bestattung 22. Oktober 1942 Plainville, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen
Tod 20. Oktober 1942 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1916 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1910 South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1920 South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1880 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1900 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [25]
Heirat 5. Juni 1879 Manhattan, New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
5. Juni 1879
Manhattan, New York, New York, USA
Sarah J. ALLEN

Notizen zu dieser Person

A famous undertaker in Hartford, Connecticut.

Quellenangaben

1 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 263; Page: 18A; Enumeration District: 0028; Image: 679.0; FHL microfilm: 2339998
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_535; Page: 2B; Enumeration District: 10-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 2A; Enumeration District: 184; Image: 848
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
8 Erin Fury, "Connecticut Births and Christenings, 1649-1906", "Connecticut Births and Christenings, 1649-1906," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/F74J-4S7 : accessed 20 May 2015), Erin Fury, 22 Feb 1851; citing ; FHL microfilm unknown.
9 Ervin L. Furrey, "New York, Marriages, 1686-1980", "New York, Marriages, 1686-1980," index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/F67W-2V1 : accessed 20 May 2015), Ervin L. Furrey and Sadie J. Allen, 05 Jun 1879; citing reference ; FHL microfilm 1,562,351.
10 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
12 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 263; Page: 18A; Enumeration District: 0028; Image: 679.0; FHL microfilm: 2339998
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_535; Page: 2B; Enumeration District: 10-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 2A; Enumeration District: 184; Image: 848
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
19 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T625_184; Page: 2A; Enumeration District: 184; Image: 848
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_535; Page: 2B; Enumeration District: 10-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_535; Page: 2B; Enumeration District: 10-57
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 263; Page: 18A; Enumeration District: 0028; Image: 679.0; FHL microfilm: 2339998
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 International Genealogical Index(R), downloaded 23 May 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
27 International Genealogical Index(R), downloaded 23 May 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
28 International Genealogical Index(R), citing film: batch: M005067, downloaded 23 May 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
29 International Genealogical Index(R), citing film: batch: M005067, downloaded 23 May 2005
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
30 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
32 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person