Hazel E. WHELAN

Hazel E. WHELAN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Hazel E. WHELAN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt etwa 1906 Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Tod USA nach diesem Ort suchen [17]
Wohnen 1928 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1. April 1940 West Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1935 West Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1910 South Windsor, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1920 West Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 West Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [23]
Departure Southampton, Hampshire, England nach diesem Ort suchen [24]
Arrival 25. August 1937 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_508; Page: 11B; Enumeration District: 2-247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 Source Citation: Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 240; Image: 166
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 269; Page: 4A; Enumeration District: 0220; Image: 7.0; FHL microfilm: 2340004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T625_180; Page: 4B; Enumeration District: 196; Image: 299
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
7 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
8 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
9 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6031; Line: 6; Page Number: 64
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
10 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_508; Page: 11B; Enumeration District: 2-247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Source Citation: Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 240; Image: 166
12 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 269; Page: 4A; Enumeration District: 0220; Image: 7.0; FHL microfilm: 2340004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T625_180; Page: 4B; Enumeration District: 196; Image: 299
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
16 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6031; Line: 6; Page Number: 64
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
17 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
18 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
19 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_508; Page: 11B; Enumeration District: 2-247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T627_508; Page: 11B; Enumeration District: 2-247
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: South Windsor, Hartford, Connecticut; Roll: T624_132; Page: 13B; Enumeration District: 0240; FHL microfilm: 1374145
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: T625_180; Page: 4B; Enumeration District: 196; Image: 299
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: West Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 269; Page: 4A; Enumeration District: 0220; Image: 7.0; FHL microfilm: 2340004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6031; Line: 6; Page Number: 64
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
25 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1937; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 6031; Line: 6; Page Number: 64
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person