Thomas Charles LYNCH

Thomas Charles LYNCH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Thomas Charles LYNCH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1. Dezember 1909 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
Bestattung 17. Juli 1966 Webster, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31] [32]
Tod 14. Juli 1966 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33] [34] [35] [36] [37]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38] [39]
Wohnen Wayne, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1944 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1960 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Wohnen 1929 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [49]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [50]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [51]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [52]
Heirat 3. September 1936 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [53]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
3. September 1936
Rochester, Monroe, New York, USA
Margaret Rita GRIMES

Notizen zu dieser Person

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 126-09-8219; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 2A; Enumeration District: 65-349B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 Web: BillionGraves.com Burial Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 13A; Enumeration District: 0175; Image: 825.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 10, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 2A; Enumeration District: 114; Image: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0190; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
18 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
19 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
20 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 126-09-8219; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 2A; Enumeration District: 65-349B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 Web: BillionGraves.com Burial Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 13A; Enumeration District: 0175; Image: 825.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 10, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 2A; Enumeration District: 114; Image: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0190; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
30 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
31 Web: BillionGraves.com Burial Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 126-09-8219; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 Web: BillionGraves.com Burial Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
37 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
38 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2018;
41 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 06; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 10; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 10; : Monroe; Page: 32
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
44 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
45 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
46 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
47 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
48 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: T624_990; Page: 9B; Enumeration District: 0190; FHL microfilm: 1375003
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
49 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 10, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 2A; Enumeration District: 114; Image: 227
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
50 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 13A; Enumeration District: 0175; Image: 825.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
51 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 2A; Enumeration District: 65-349B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
52 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 2A; Enumeration District: 65-349B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
53 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person