George William RIEDL

George William RIEDL

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name George William RIEDL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. September 1893 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung 13. Dezember 1945 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Tod 11. Dezember 1945 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25] [26] [27]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1939 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1942 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Heirat 12. Juli 1924 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36] [37] [38]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
12. Juli 1924
Rochester, Monroe, New York, USA
Marie Evelyn STEWART

Notizen zu dieser Person

Still Living.

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 11A; Enumeration District: 249; Image: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 14B; Enumeration District: 0095; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 7B; Enumeration District: 65-323
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 24; : Monroe; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
12 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 509
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
13 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
14 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 11A; Enumeration District: 249; Image: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 14B; Enumeration District: 0095; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 7B; Enumeration District: 65-323
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 24; : Monroe; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 509
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
23 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
24 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
28 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 11A; Enumeration District: 249; Image: 871
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 24; : Monroe; Page: 3
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 7B; Enumeration District: 65-323
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2851; Page: 7B; Enumeration District: 65-323
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 15, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 14B; Enumeration District: 0095; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T624_993; Page: 5A; Enumeration District: 0205; FHL microfilm: 1375006
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
35 U.S., World War II Draft Registration Cards, 1942, The National Archives at St. Louis; St. Louis, Missouri; World War II Draft Cards (Fourth Registration) for the State of New York; Record Group Title: Records of the Selective Service System, 1926-1975; Record Group Number: 147; Box or Roll Number: 509
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
36 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
37 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person