Alice F ORELUP

Alice F ORELUP

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Alice F ORELUP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 5. Oktober 1895 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Tod 24. November 1993 Chester, Middlesex, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [18] [19] [20]
Wohnen 1935 Yonkers, Westchester, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1925 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen Chester, Middlesex, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1940 Yonkers, Westchester, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1910 Knox, Albany, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1920 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Bridgeport, Fairfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [27]
Heirat 2. Oktober 1926 Manhattan, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [28] [29]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
2. Oktober 1926
Manhattan, Kings, New York, USA
Stephen L MANNION

Quellenangaben

1 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Page: 2; Enumeration District: 0046; FHL microfilm: 1240132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bridgeport Ward 9, Fairfield, Connecticut; Roll: T625_176; Page: 2B; Enumeration District: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
3 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Knox, Albany, New York; Roll: T624_922; Page: 4A; Enumeration District: 0141; FHL microfilm: 1374935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
4 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
5 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2003;
6 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
7 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 094-36-3158; Issue State: New York; Issue Date: 1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
8 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Yonkers, Westchester, New York; Roll: m-t0627-02863; Page: 7B; Enumeration District: 68-14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
9 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
10 New York City, Marriage Indexes, 1907-1995, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Manhattan; Volume Number: 10
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
11 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Page: 2; Enumeration District: 0046; FHL microfilm: 1240132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
12 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bridgeport Ward 9, Fairfield, Connecticut; Roll: T625_176; Page: 2B; Enumeration District: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
13 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Knox, Albany, New York; Roll: T624_922; Page: 4A; Enumeration District: 0141; FHL microfilm: 1374935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
14 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
15 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2003;
16 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 094-36-3158; Issue State: New York; Issue Date: 1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
17 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Yonkers, Westchester, New York; Roll: m-t0627-02863; Page: 7B; Enumeration District: 68-14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
18 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
19 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2003;
20 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 094-36-3158; Issue State: New York; Issue Date: 1962
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Yonkers, Westchester, New York; Roll: m-t0627-02863; Page: 7B; Enumeration District: 68-14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
22 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
23 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2003;
24 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Yonkers, Westchester, New York; Roll: m-t0627-02863; Page: 7B; Enumeration District: 68-14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
25 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Knox, Albany, New York; Roll: T624_922; Page: 4A; Enumeration District: 0141; FHL microfilm: 1374935
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006;
26 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Bridgeport Ward 9, Fairfield, Connecticut; Roll: T625_176; Page: 2B; Enumeration District: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
27 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Bridgeport, Fairfield, Connecticut; Page: 2; Enumeration District: 0046; FHL microfilm: 1240132
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004;
28 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;
29 New York, New York, Marriage Certificate Index 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2014;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person