Sophia Anna EISMANN

Sophia Anna EISMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Sophia Anna EISMANN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 7. April 1866 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Tod 12. März 1947 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1870 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1921 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1. Juni 1875 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1. Juni 1875 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
obit 1947 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Heirat 30. Oktober 1888 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
30. Oktober 1888
Rochester, Monroe, New York, USA
George J HILBERT

Quellenangaben

1 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 9A; Enumeration District: 0073; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387476; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
14 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
16 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 9A; Enumeration District: 0073; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387476; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
23 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 34
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 02; City: Rochester Ward 11; : Monroe
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1450; Page: 22A; Enumeration District: 0066; Image: 1053.0; FHL microfilm: 2341185
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T625_1122; Page: 11A; Enumeration District: 131; Image: 783
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
30 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: M593_969; Page: 363A; Image: 387476; Family History Library Film: 552468
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: 1075; Page: 9A; Enumeration District: 0073; FHL microfilm: 1241075
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 11, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 2B; Enumeration District: 0109; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
34 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 New York, State Census, 1875
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 14 Mar 1947 - Page 24, 14 Mar 1947
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Democrat and Chronicle;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person