Agnes L BOEHM

Agnes L BOEHM

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Agnes L BOEHM [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 5. Februar 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Tod 17. Dezember 1990 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1938 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1959 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Heirat 1. September 1933 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27] [28]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1. September 1933
Rochester, Monroe, New York, USA
Joseph George HILBERT

Quellenangaben

1 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 067-38-8333; Issue State: New York; Issue Date: 1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 11B; Enumeration District: 0126; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 5B; Enumeration District: 0172; Image: 711.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 41
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 4A; Enumeration District: 248; Image: 831
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 067-38-8333; Issue State: New York; Issue Date: 1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 11B; Enumeration District: 0126; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 5B; Enumeration District: 0172; Image: 711.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 41
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 4A; Enumeration District: 248; Image: 831
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 067-38-8333; Issue State: New York; Issue Date: 1963
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 4A; Enumeration District: 248; Image: 831
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 41
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 09; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 20; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 5B; Enumeration District: 0172; Image: 711.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 20, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 11B; Enumeration District: 0126; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person