Carl J. EISMANN

Carl J. EISMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Carl J. EISMANN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 3. Februar 1906 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Tod 27. April 1992 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Heirat 9. Dezember 1922 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
9. Dezember 1922
Rochester, Monroe, New York, USA
Lillian Grace KRAUTWURST

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 5A; Enumeration District: 261; Image: 1062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 1B; Enumeration District: 0160; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 061-20-6998; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 U.S., Department of Veterans Affairs BIRLS Death File, 1850-2010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2850; Page: 8A; Enumeration District: 65-311
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0184; Image: 83.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 5A; Enumeration District: 261; Image: 1062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 1B; Enumeration District: 0160; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 061-20-6998; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 U.S., Department of Veterans Affairs BIRLS Death File, 1850-2010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2850; Page: 8A; Enumeration District: 65-311
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0184; Image: 83.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Number: 061-20-6998; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 U.S., Department of Veterans Affairs BIRLS Death File, 1850-2010
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 19A; Enumeration District: 0184; Image: 83.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 05; City: Rochester Ward 11; : Monroe; Page: 01
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2850; Page: 8A; Enumeration District: 65-311
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2850; Page: 8A; Enumeration District: 65-311
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 1B; Enumeration District: 0160; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 5A; Enumeration District: 261; Image: 1062
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person