Ethel Lillian PALMER

Ethel Lillian PALMER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ethel Lillian PALMER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 23. Januar 1905 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
Bestattung Coventry, Tolland, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [20] [21]
Tod 12. April 1985 Manchester, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [22] [23] [24] [25]
Wohnen 1929 Manchester, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1930 Manchester, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1948 Manchester, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen Manchester, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1920 Coventry, Tolland, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Coventry, Tolland, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [31]
Heirat 15. Juli 1922 Winooski, Chittenden, Vermont, USA nach diesem Ort suchen [32]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
15. Juli 1922
Winooski, Chittenden, Vermont, USA
Leroy Marcus ASPINWALL

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T624_143; Page: 5B; Enumeration District: 0554; FHL microfilm: 1374156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
5 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T625_198; Page: 3B; Enumeration District: 308; Image: 69
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
6 Vermont, Marriage Records, 1909-2008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 049-09-6495; Issue State: Connecticut; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Manchester, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 0155; Image: 920.0; FHL microfilm: 2340002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T624_143; Page: 5B; Enumeration District: 0554; FHL microfilm: 1374156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T625_198; Page: 3B; Enumeration District: 308; Image: 69
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 Vermont, Marriage Records, 1909-2008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
18 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 049-09-6495; Issue State: Connecticut; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Manchester, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 0155; Image: 920.0; FHL microfilm: 2340002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 Web: Connecticut, Find A Grave Index, 1636-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 049-09-6495; Issue State: Connecticut; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Manchester, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 0155; Image: 920.0; FHL microfilm: 2340002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
29 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T625_198; Page: 3B; Enumeration District: 308; Image: 69
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
31 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Coventry, Tolland, Connecticut; Roll: T624_143; Page: 5B; Enumeration District: 0554; FHL microfilm: 1374156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
32 Vermont, Marriage Records, 1909-2008
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person