Ashbel GILMAN

Ashbel GILMAN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ashbel GILMAN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1823 Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Bestattung East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [18] [19]
Taufe 1824 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [20]
Tod 26. März 1909 Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24]
Wohnen 1860 Harwinton, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1880 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1850 East Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [28]
Heirat 13. Mai 1846

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
13. Mai 1846
Celia BISSELL

Quellenangaben

1 "FamilySearch," database, FamilySearch ?, accessed 2 Feb 2011), entry for Ann Abbe, person ID 273Q-VW K.
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: (http://new.familysearch.org);
2 Connecticut, Deaths and Burials Index, 1650-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: M432_41; Page: 362A; Image: 464
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
4 U.S., Sons of the American Revolution Membership Applications, 1889-1970, Volume: 291; SAR Membership Number: 58073
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 Connecticut, Hale Cemetery Inscriptions, 1675-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 99; Family History Film: 1254099; Page: 436C; Enumeration District: 049; Image: 0872
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
7 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 3A; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Harwinton, Litchfield, Connecticut; Roll: M653_82; Page: 637; Image: 52; Family History Library Film: 803082
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
11 Connecticut, Deaths and Burials Index, 1650-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: M432_41; Page: 362A; Image: 464
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 U.S., Sons of the American Revolution Membership Applications, 1889-1970, Volume: 291; SAR Membership Number: 58073
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 Connecticut, Hale Cemetery Inscriptions, 1675-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 99; Family History Film: 1254099; Page: 436C; Enumeration District: 049; Image: 0872
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 3A; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
17 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Harwinton, Litchfield, Connecticut; Roll: M653_82; Page: 637; Image: 52; Family History Library Film: 803082
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 Connecticut, Deaths and Burials Index, 1650-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 Connecticut, Hale Cemetery Inscriptions, 1675-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 "FamilySearch," database, FamilySearch ?, accessed 2 Feb 2011), entry for Ann Abbe, person ID 273Q-VW K.
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: (http://new.familysearch.org);
21 Connecticut, Deaths and Burials Index, 1650-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 U.S., Sons of the American Revolution Membership Applications, 1889-1970, Volume: 291; SAR Membership Number: 58073
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 Connecticut, Hale Cemetery Inscriptions, 1675-1934
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1860 USA Federal Census, Year: 1860; Census Place: Harwinton, Litchfield, Connecticut; Roll: M653_82; Page: 637; Image: 52; Family History Library Film: 803082
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 19, Monroe, New York; Roll: 1077; Page: 3A; Enumeration District: 0116; FHL microfilm: 1241077
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
27 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 99; Family History Film: 1254099; Page: 436C; Enumeration District: 049; Image: 0872
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
28 1850 USA Federal Census, Year: 1850; Census Place: East Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: M432_41; Page: 362A; Image: 464
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person