Anna Maria SCHICKER

Anna Maria SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Anna Maria SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 29. April 1878 [18]
Geburt 18. April 1878 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Tod 15. Juni 1952 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31] [32]
Wohnen 1892 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33] [34]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1948 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1919 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1929 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [44]
Wohnen 1880 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [45]
Wohnen 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [46]
Ethnicity/Relig. [47]
Heirat 3. September 1900 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
3. September 1900
Rochester, Monroe, New York, USA
Michael Frank STORANDT

Quellenangaben

1 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 864; Family History Film: 1254864; Page: 303B; Enumeration District: 105; Image: 0428
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 3B; Enumeration District: 255; Image: 882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 11B; Enumeration District: 0190; Image: 492.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 03
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4A; Enumeration District: 65-361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 3A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
8 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
9 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 7B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
15 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2015;
16 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
18 Most Holy Redeemer Baptisms (1867-1918), Roll 6, Item 12, Diocese of Rochester records at Nazareth College Library, 1878, #45
19 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 864; Family History Film: 1254864; Page: 303B; Enumeration District: 105; Image: 0428
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
20 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 3B; Enumeration District: 255; Image: 882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 11B; Enumeration District: 0190; Image: 492.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
22 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 03
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4A; Enumeration District: 65-361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
25 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 3A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 Most Holy Redeemer Baptisms (1867-1918), Roll 6, Item 12, Diocese of Rochester records at Nazareth College Library, 1878, #45
29 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 7B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
31 Obit, Sebastian M. Schicker, Roch Democrat & Chroncile, Jan 12, 1919, 29:4
32 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
33 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, State Census, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
35 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 03
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 01; Assembly District: 01; City: Rochester Ward 22; : Monroe; Page: 9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
37 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: T624_991; Page: 3A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1375004
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
39 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4A; Enumeration District: 65-361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 4A; Enumeration District: 65-361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
42 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
43 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 11B; Enumeration District: 0190; Image: 492.0; FHL microfilm: 2341190
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
44 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 3B; Enumeration District: 255; Image: 882
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
45 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 864; Family History Film: 1254864; Page: 303B; Enumeration District: 105; Image: 0428
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
46 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Rochester Ward 8, Monroe, New York; Roll: 1074; Page: 7B; Enumeration District: 0063; FHL microfilm: 1241074
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
47 Golden Jubilee Souvenir Book, Holy Redeemer Church, 1917, from Rundel Library,Rochester NY
48 Diocese of Rochester records on microfilm at Nazareth College Library, Roll, 6, Item 19, Most Holy Redeemer Church, Marriages, p268, #27

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person