Genevieve Della SCHICKER

Genevieve Della SCHICKER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Genevieve Della SCHICKER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 22. Mai 1916 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [10] [11] [12] [13] [14]
Bestattung Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [15]
Tod 29. März 1971 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [16] [17]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [18]
Wohnen 1960 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [19]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 26. November 1947 [25]
Comment 3
Heirat 25. November 1937 New York, USA nach diesem Ort suchen [26] [27]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
25. November 1937
New York, USA
Joseph A. SCHEID

Notizen zu dieser Person

(Medical):heavy smoker

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 13A; Enumeration District: 257; Image: 940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
3 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 14A; Enumeration District: 0119; Image: 367.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2848; Page: 5B; Enumeration District: 65-225
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
9 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
10 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 13A; Enumeration District: 257; Image: 940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 14A; Enumeration District: 0119; Image: 367.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
12 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
13 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2848; Page: 5B; Enumeration District: 65-225
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
14 Smith/Knights/Schicker Bible (1873), owned by Arvilla Schicker Everingham in 1983 Schicker/Knights Bible (1886), owned by Trudy Schicker Rowe in 1996
15 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
16 Smith/Knights/Schicker Bible (1873), owned by Arvilla Schicker Everingham in 1983
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
18 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Rochester Ward 08; : Monroe; Page: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
19 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2848; Page: 5B; Enumeration District: 65-225
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2848; Page: 5B; Enumeration District: 65-225
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1454; Page: 14A; Enumeration District: 0119; Image: 367.0; FHL microfilm: 2341189
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 22, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 13A; Enumeration District: 257; Image: 940
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 Monroe Co NY Surrogate Court Record #1948-170, Arvilla Schicker
26 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
27 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person