Reinhard George VOGLER

Reinhard George VOGLER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Reinhard George VOGLER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Name Reinhardt C. VOGLER

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 9. Juni 1906 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Bestattung Webster, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [22]
Tod März 1986 Webster, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [23] [24]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1957 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1951 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Heirat 1. August 1929 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [34] [35]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1. August 1929
Rochester, Monroe, New York, USA
Rose C. SCHICKER

Notizen zu dieser Person

1930 USA Federal Census about Reinhardt C Vogler Name: Reinhardt C Vogler Home in 1930: Rochester, Monroe, New York Age: 23 Estimated birth year: abt 1907 Birthplace: New York Relation to Head of House: Son-in-law Spouse's name: Rose C Race: White View image Neighbors: View others on page Household Members: Name Age Frank Schicker 53 Caroline Schicker 53 Reinhardt C Vogler 23 Rose C Vogler 21 Social Security Death Index about Reinhard Vogler Name: Reinhard Vogler SSN: 128-05-6004 Last Residence: 14580 Webster, Monroe, New York, USA of America Born: 9 Jun 1906 Died: Mar 1986 State (Year) SSN issued: New York (Before 1951 )

Quellenangaben

1 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15B; Enumeration District: 70; Image: 157
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
2 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
3 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-6004; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 3B; Enumeration District: 65-362
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T624_989; Page: 10B; Enumeration District: 0065; FHL microfilm: 1375002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
10 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 7A; Enumeration District: 0031; Image: 517.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
11 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
12 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
13 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15B; Enumeration District: 70; Image: 157
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
14 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
15 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-6004; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
16 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 3B; Enumeration District: 65-362
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
17 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
18 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T624_989; Page: 10B; Enumeration District: 0065; FHL microfilm: 1375002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 7A; Enumeration District: 0031; Image: 517.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
21 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
22 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
24 U.S., Social Security Death Index, 1935-Current, Number: 128-05-6004; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T625_1121; Page: 15B; Enumeration District: 70; Image: 157
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
26 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 11
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
27 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 05; : Monroe; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
28 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1449; Page: 7A; Enumeration District: 0031; Image: 517.0; FHL microfilm: 2341184
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
29 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 5, Monroe, New York; Roll: T624_989; Page: 10B; Enumeration District: 0065; FHL microfilm: 1375002
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
30 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
31 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
32 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 3B; Enumeration District: 65-362
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2852; Page: 3B; Enumeration District: 65-362
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
35 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person