Dorothy Estella ALLEN
♀ Dorothy Estella ALLEN
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Dorothy Estella ALLEN | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] | ||
Name | Estalla Wadsworth ALLEN | |||
Beruf | Cook | 1944 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 25. Juli 1897 | Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen | [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] |
Bestattung | 30. August 1944 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | [22] [23] [24] |
Tod | 25. August 1944 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | [25] [26] [27] [28] |
Wohnen | 1935 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | [29] |
Wohnen | 1940 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | [30] |
Wohnen | 1938 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | [31] |
Wohnen | 1910 | Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen | [32] |
Wohnen | 25. Juli 1897 | ||
Wohnen | 29. September 1898 | ||
Wohnen | 1900 | Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen | [33] |
Wohnen | 1933 | San Diego, San Diego, California, USA nach diesem Ort suchen | |
Heirat | Hartford, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen | ||
Heirat | etwa 1936 | ||
Heirat | 27. November 1919 | Addison, Steuben, New York, USA nach diesem Ort suchen | [34] [35] [36] [37] |
Heirat | 10. Januar 1917 | Chadwicks, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen | [38] [39] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
Hartford, Hartford, Connecticut, USA |
Edward Logan GARTLAND |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
27. November 1919 Addison, Steuben, New York, USA |
Llewellyn BURRELL |
|
Heirat | Ehepartner | Kinder |
10. Januar 1917 Chadwicks, Oneida, New York, USA |
Leslie C. DIETZ |
|
Notizen zu dieser Person
GARTLAND, Dorothy Estella, Aug. 25, age 54, services in the Chapel of the Benbough Mortuary, Wedndsday, 10 a.m., Chaplain Duston Tucker, officiating. Interment Ft. Rosecrans.
Quellenangaben
1 | U.S. National Cemetery Interment Control Forms, 1928-1962 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
2 | Web: California, Find A Grave Index, 1775-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
3 | U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 Autor: National Cemetery Administration Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
4 | California, Death Index, 1940-1997, Date: 1944-08-25 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
5 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; |
6 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
7 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004; |
8 | New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
9 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 9, Hartford, Connecticut; Roll: T624_133; Page: 9A; Enumeration District: 0199; FHL microfilm: 1374146 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006; |
10 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
11 | New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017; |
12 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
13 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
14 | Web: California, Find A Grave Index, 1775-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
15 | California, Death Index, 1940-1997, Date: 1944-08-25 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
16 | Birth Certificate |
17 | Birth Certificate |
18 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
19 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004; |
20 | New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
21 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 9, Hartford, Connecticut; Roll: T624_133; Page: 9A; Enumeration District: 0199; FHL microfilm: 1374146 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006; |
22 | U.S. National Cemetery Interment Control Forms, 1928-1962 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
23 | Web: California, Find A Grave Index, 1775-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
24 | U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 Autor: National Cemetery Administration Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
25 | U.S. National Cemetery Interment Control Forms, 1928-1962 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
26 | Web: California, Find A Grave Index, 1775-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; |
27 | U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 Autor: National Cemetery Administration Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
28 | California, Death Index, 1940-1997, Date: 1944-08-25 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; |
29 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
30 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
31 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011; |
32 | 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Hartford Ward 9, Hartford, Connecticut; Roll: T624_133; Page: 9A; Enumeration District: 0199; FHL microfilm: 1374146 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2006; |
33 | 1900 USA Federal Census, Year: 1900; Census Place: Hartford, Hartford, Connecticut; Roll: 137; Page: 6A; Enumeration District: 0163; FHL microfilm: 1240137 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2004; |
34 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
35 | New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017; |
36 | New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
37 | New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017; |
38 | New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
39 | New York, Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016; |
Datenbank
Titel | Family Grimes Stammbaum |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2019-08-30 07:34:24.0 |
Einsender | Michael Grimes |
oneofmanyangels@gmail.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |