Joseph PFEIFER

Joseph PFEIFER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Joseph PFEIFER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Name Joseph PFEIFFER
Beruf Day Laborer 1899 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Beruf Dishwasher 1947 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Beruf Blacksmith Helper 1904 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 18. Juni 1870 Bayern, Germany nach diesem Ort suchen [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
Bestattung 2. Dezember 1947 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Tod 29. November 1947 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [33] [34]
Wohnen 1927 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1. Juni 1915 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1. Juni 1925 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1905 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1918 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1. April 1940 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1920 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1930 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [42]
Wohnen Henrietta, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1910 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [43]
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen
Arrival 1871 [44]
Arrival 1891 [45]
Arrival 1890 [46]
Heirat 27. Mai 1899 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [47]
Heirat 2. Oktober 1909 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [48] [49] [50]
Heirat 12. Oktober 1912 Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [51] [52] [53] [54]
Heirat Rochester, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [55]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
27. Mai 1899
Rochester, Monroe, New York, USA
Margaretha SCHICKER
Heirat Ehepartner Kinder
2. Oktober 1909
Rochester, Monroe, New York, USA
Otilla DRECHSLER
Heirat Ehepartner Kinder
12. Oktober 1912
Rochester, Monroe, New York, USA
Clara Mary Berl KRUN
Heirat Ehepartner Kinder

Rochester, Monroe, New York, USA

Notizen zu dieser Person

Buried in Holy Sepulchre Cemetery, 54 Tier, 39 Section

Quellenangaben

1 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
2 "FamilySearch," database, FamilySearch ?, accessed 20 Feb 2011), entry for Clara Mary Krun BERL, pers on ID K2CH-YH9.
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: (http://new.familysearch.org);
3 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 15B; Enumeration District: 0168; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
4 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 86
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
5 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
6 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
7 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
8 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 19B; Enumeration District: 0086; Image: 551.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
9 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 11B; Enumeration District: 162; Image: 746
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
10 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5A; Enumeration District: 65-166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
11 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
12 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;
13 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
14 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
15 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
16 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
17 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
18 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 15B; Enumeration District: 0168; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
19 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 86
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
20 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
21 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
22 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
23 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 19B; Enumeration District: 0086; Image: 551.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
24 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 11B; Enumeration District: 162; Image: 746
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
25 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5A; Enumeration District: 65-166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
26 Source Citation: Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1455; Page: 28B; Enumeration District: 184; Image: 102.0
27 Baptisms, Holy Redeemer Church, Diocese of Rochester microfilm at Nazareth College Library, Roll 6, Item 12, 1901 #11, & 1904 #59
28 Source Citation: Year: 1920;Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 11B; Enumeration District: 162; Image: 744
29 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
30 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
31 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
32 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
33 U.S., Find A Grave Index, 1700s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
34 New York, Death Index, 1880-1956, New York Department of Health; Albany, NY; NY State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
35 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
36 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 14
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2012;
37 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 04; City: Rochester Ward 14; : Monroe; Page: 7
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
38 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: E.D. 04; City: Rochester Ward 17; : Monroe; Page: 86
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
39 U.S. City Directories, 1941
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
40 1940 USA Federal Census, Year: 1940; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: T627_2846; Page: 5A; Enumeration District: 65-166
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.;
41 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 11B; Enumeration District: 162; Image: 746
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
42 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 19B; Enumeration District: 0086; Image: 551.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
43 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 15B; Enumeration District: 0168; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
44 1920 USA Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 14, Monroe, New York; Roll: T625_1123; Page: 11B; Enumeration District: 162; Image: 746
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
45 1930 USA Federal Census, Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 19B; Enumeration District: 0086; Image: 551.0; FHL microfilm: 2341186
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
46 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 15B; Enumeration District: 0168; FHL microfilm: 1375005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc;
47 Diocese of Rochester records on microfilm at Nazareth College Library, Roll, 6, Item 19, Most Holy Redeemer Church, Marriages, p258, #18
48 Source Citation: Year: 1910; Census Place: Rochester Ward 17, Monroe, New York; Roll: T624_992; Page: 15B; Enumeration District: 168; Image: 1055
49 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
50 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;
51 "FamilySearch," database, FamilySearch ?, accessed 20 Feb 2011), entry for Clara Mary Krun BERL, pers on ID K2CH-YH9.
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: (http://new.familysearch.org);
52 Source Citation: Year: 1930; Census Place: Rochester, Monroe, New York; Roll: 1451; Page: 19B; Enumeration District: 86; Image: 551.0
53 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
54 New York, Marriages, 1847-1849; 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
55 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2017;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person