Ellen Adelia WADSWORTH

Ellen Adelia WADSWORTH

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Ellen Adelia WADSWORTH [1] [2] [3] [4] [5]
Name Eleanor A WADSWORTH
Name Nellie A WADSWORTH [6]
Name Nellie A. WADSWORTH

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. September 1862 Bath, Sagadahoc, Maine, USA nach diesem Ort suchen [7] [8] [9] [10]
Wohnen 1911 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [11]
Wohnen 1900 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1870 Bath, Sagadahoc, Maine, USA nach diesem Ort suchen [12]
Wohnen 1910 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [13]
Wohnen 1880 Bath, Sagadahoc, Maine, USA nach diesem Ort suchen [14]
Heirat 12. Juni 1888 Portland, Cumberland, Maine, USA nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
12. Juni 1888
Portland, Cumberland, Maine, USA
Herbert Franklin WOODWARD

Quellenangaben

1 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: 488; Family History Film: 1254488; Page: 30D; Enumeration District: 143; Image: 0064
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
2 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Portland Ward 7, Cumberland, Maine; Roll: T624_539; Page: 8B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1374552
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
3 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: M593_557; Page: 287A; Image: 18690; Family History Library Film: 552056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2009;
4 Maine, Marriage Index, 1670-1921
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
5 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
6 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; Pre 1892 Delayed Returns; Roll Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
7 International Genealogical Index(R), citing microfilm 452108, page 0057, reference number 22238 , downloaded 21 Aug 2007
Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Copyright (c) 1980, 2002;
8 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: 488; Family History Film: 1254488; Page: 30D; Enumeration District: 143; Image: 0064
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
9 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Portland Ward 7, Cumberland, Maine; Roll: T624_539; Page: 8B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1374552
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
10 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: M593_557; Page: 287A; Image: 18690; Family History Library Film: 552056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2009;
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2011;
12 1870 USA Federal Census, Year: 1870; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: M593_557; Page: 287A; Image: 18690; Family History Library Film: 552056
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2009;
13 1910 USA Federal Census, Year: 1910; Census Place: Portland Ward 7, Cumberland, Maine; Roll: T624_539; Page: 8B; Enumeration District: 0088; FHL microfilm: 1374552
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
14 1880 USA Federal Census, Year: 1880; Census Place: Bath, Sagadahoc, Maine; Roll: 488; Family History Film: 1254488; Page: 30D; Enumeration District: 143; Image: 0064
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2010;
15 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; Pre 1892 Delayed Returns; Roll Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
16 Maine, Marriage Index, 1670-1921
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;
17 Maine, Marriage Records, 1713-1922, Maine State Archives; Cultural Building, 84 State House Station, Augusta, ME 04333-0084; Pre 1892 Delayed Returns; Roll Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2010;
18 Maine, Marriage Index, 1670-1921
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Lehi, UT, USA; Date: 2016;

Datenbank

Titel Family Grimes Stammbaum
Beschreibung
Hochgeladen 2019-08-30 07:34:24.0
Einsender user's avatar Michael Grimes
E-Mail oneofmanyangels@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person