Josephine STERZINGER

Josephine STERZINGER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Josephine STERZINGER [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 19. März 1873 Mellrichstadt, Rhon-Grabfeld, Bayern, Deutschland nach diesem Ort suchen [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Bestattung Williamsville, Erie County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [21]
Tod 15. Februar 1960 Buffalo, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [22] [23]
Wohnen 1920 Amherst, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen 1930 Amherst, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1910 Amherst, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1900 Buffalo Ward 18, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1. Juni 1915 Amherst, Erie, New York, United States nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen Mettricholadt nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1905 Amherst, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1951 Buffalo, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen Williamsville, Erie, New York, USA nach diesem Ort suchen [32]
Arrival 13. August 1892 New York, New York nach diesem Ort suchen [33] [34] [35] [36]
Departure Hamburg nach diesem Ort suchen [37]
Heirat 1895 [38]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1895
Alwin DONIUS

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Amherst; County: Erie; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 595; Line: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 07; City: Amherst; County: Erie; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 18, Erie, New York; Page: 28; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1241030
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 18B; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Amherst, Erie, New York; Page: 19B; Enumeration District: 0358; FHL microfilm: 2341156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T625_1099; Page: 4A; Enumeration District: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Amherst; County: Erie; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 595; Line: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 07; City: Amherst; County: Erie; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 18, Erie, New York; Page: 28; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1241030
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 18B; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Amherst, Erie, New York; Page: 19B; Enumeration District: 0358; FHL microfilm: 2341156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T625_1099; Page: 4A; Enumeration District: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T625_1099; Page: 4A; Enumeration District: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Amherst, Erie, New York; Page: 19B; Enumeration District: 0358; FHL microfilm: 2341156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 18B; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 18, Erie, New York; Page: 28; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1241030
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 02; Assembly District: 07; City: Amherst; County: Erie; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 595; Line: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 New York, State Census, 1905, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1905; Election District: A.D. 07 E.D. 01; City: Amherst; County: Erie; Page: 38
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 New York State, Death Index, 1957-1968, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Death Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 595; Line: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T624_938; Page: 18B; Enumeration District: 0242; FHL microfilm: 1374951
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Amherst, Erie, New York; Page: 19B; Enumeration District: 0358; FHL microfilm: 2341156
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Amherst, Erie, New York; Roll: T625_1099; Page: 4A; Enumeration District: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 595; Line: 19
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Buffalo Ward 18, Erie, New York; Page: 28; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1241030
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Stammbaum Stmstg
Beschreibung
Hochgeladen 2020-04-22 14:23:00.0
Einsender user's avatar Mathias Steinmüller
E-Mail masteinmueller@t-online.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person