Eva Mae CRAMER

Eva Mae CRAMER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Eva Mae CRAMER [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 2. Juli 1895 Rome, Oneida County, New York, USA nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Bestattung Oriskany, Oneida County, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [25]
Tod 15. Oktober 1985 Oriskany, Oneida, New York, United States nach diesem Ort suchen [26] [27]
Heirat April 1910 Bromsgrove, Worcestershire nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1916 Utica, New York, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1925 Whitestown, Oneida nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") New York nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1935 Whitestown, Oneida, New York nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1940 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1930 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1. Juni 1915 Whitestown, Oneida, New York, United States nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1920 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1900 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1910 Whitestown, Oneida, New York, USA nach diesem Ort suchen [38]
Heirat 15. Mai 1920 Utica, Oneida, New York, United States nach diesem Ort suchen [39]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
15. Mai 1920
Utica, Oneida, New York, United States
Charles Frederick HEMMING

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 3A; Enumeration District: 0181; FHL microfilm: 1375066
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 7; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 6A; Enumeration District: 204
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 England & Wales, Civil Registration Marriage Index, 1837-1915
Autor: FreeBMD
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 3A; Enumeration District: 0181; FHL microfilm: 1375066
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 7; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 6A; Enumeration District: 204
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 England & Wales, Civil Registration Marriage Index, 1837-1915
Autor: FreeBMD
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 08; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 13
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: m-t0627-02702; Page: 2B; Enumeration District: 33-111
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 2B; Enumeration District: 0174; FHL microfilm: 2341357
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 02; City: Whitestown; County: Oneida; Page: 16
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T625_1245; Page: 6A; Enumeration District: 204
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Page: 7; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241134
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Whitestown, Oneida, New York; Roll: T624_1053; Page: 3A; Enumeration District: 0181; FHL microfilm: 1375066
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 New York, County Marriage Records, 1847-1849, 1907-1936
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Schmidt
Beschreibung My family tree of the Odenwald region as of July 2020. Still a work in progress
Hochgeladen 2020-07-11 10:31:34.0
Einsender user's avatar Regina McAnally
E-Mail rmcana64@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person