Sibylle Catherina 'Kate' UHL

Sibylle Catherina 'Kate' UHL

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Sibylle Catherina 'Kate' UHL [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 30. Januar 1838 Hahnlein, Starkenburg, Darmstadt, Hessen, Germany nach diesem Ort suchen [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Bestattung Louisville, Jefferson County, Kentucky, United States of America nach diesem Ort suchen [21]
Tod 11. August 1925 Louisville, Jefferson County, Kentucky, United States of America nach diesem Ort suchen [22] [23] [24]
Wohnen Auerbach nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1878 Cincinnati, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1910 Connersville Ward 2, Fayette, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1880 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1900 Louisville Ward 1, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1870 Louisville Ward 6, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Departure Rotterdam nach diesem Ort suchen [31]
Arrival 21. Oktober 1892 New York, New York nach diesem Ort suchen [32]
Heirat 14. Februar 1858 Cincinnatti, Hamilton, Ohio, United States nach diesem Ort suchen [33]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
14. Februar 1858
Cincinnatti, Hamilton, Ohio, United States
Francis Thomas John MORAT

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 6, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_474; Page: 625B; Family History Library Film: 545973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 1, Jefferson, Kentucky; Page: 19; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1240529
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 423; Page: 427B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Ohio, County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1952; Roll: 03
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Connersville Ward 2, Fayette, Indiana; Roll: T624_348; Page: 2A; Enumeration District: 0022; FHL microfilm: 1374361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 599; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 6, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_474; Page: 625B; Family History Library Film: 545973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 1, Jefferson, Kentucky; Page: 19; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1240529
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 423; Page: 427B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Connersville Ward 2, Fayette, Indiana; Roll: T624_348; Page: 2A; Enumeration District: 0022; FHL microfilm: 1374361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 599; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 599; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Connersville Ward 2, Fayette, Indiana; Roll: T624_348; Page: 2A; Enumeration District: 0022; FHL microfilm: 1374361
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 423; Page: 427B; Enumeration District: 125
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 1, Jefferson, Kentucky; Page: 19; Enumeration District: 0013; FHL microfilm: 1240529
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 6, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_474; Page: 625B; Family History Library Film: 545973
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 599; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1892; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 599; Line: 1
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Ohio, County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Schmidt
Beschreibung My family tree of the Odenwald region as of July 2020. Still a work in progress
Hochgeladen 2020-07-11 10:31:34.0
Einsender user's avatar Regina McAnally
E-Mail rmcana64@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person