Pauline SPAAR

Pauline SPAAR

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Pauline SPAAR [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 26. Februar 1898 Mechanicsville, New York nach diesem Ort suchen [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Bestattung Winsted, Litchfield County, Connecticut, United States of America nach diesem Ort suchen [25]
Tod 30. Mai 1994 Torrington, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [26] [27] [28] [29]
Wohnen 1927 Winsted, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen Winchester, Litchfield, Connecticut nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") Connecticut nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1910 Bedford, Westchester, New York, USA nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1920 Winchester, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1935 Winsted, Litchfield, Connecticut nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1940 Winsted, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1930 Winchester, Litchfield, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1. Juni 1915 Bedford, Westchester, New York, United States nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1900 Halfmoon, Saratoga, New York, USA nach diesem Ort suchen [39]
Heirat 8. Februar 1919 Winchester, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [40]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
8. Februar 1919
Winchester, Connecticut, USA
Winthrop Vosberg HAYES

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Halfmoon, Saratoga, New York; Page: 11; Enumeration District: 0117; FHL microfilm: 1241158
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Bedford; County: Westchester; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bedford, Westchester, New York; Roll: T624_1088; Page: 1B; Enumeration District: 0004; FHL microfilm: 1375101
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947, The National Archives in St. Louis, Missouri; St. Louis, Missouri; WWII Draft Registration Cards for Connecticut, 10/16/1940-03/31/1947; Record Group: Records of the Selective Service System, 147; Box
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Halfmoon, Saratoga, New York; Page: 11; Enumeration District: 0117; FHL microfilm: 1241158
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Bedford; County: Westchester; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bedford, Westchester, New York; Roll: T624_1088; Page: 1B; Enumeration District: 0004; FHL microfilm: 1375101
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Connecticut Death Index, 1949-2012
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Bedford, Westchester, New York; Roll: T624_1088; Page: 1B; Enumeration District: 0004; FHL microfilm: 1375101
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Roll: T625_187; Page: 5A; Enumeration District: 232
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Winsted, Litchfield, Connecticut; Roll: m-t0627-00511; Page: 3A; Enumeration District: 3-83
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Winchester, Litchfield, Connecticut; Page: 2A; Enumeration District: 0054; FHL microfilm: 2340005
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 04; Assembly District: 04; City: Bedford; County: Westchester; Page: 22
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Halfmoon, Saratoga, New York; Page: 11; Enumeration District: 0117; FHL microfilm: 1241158
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Schmidt
Beschreibung My family tree of the Odenwald region as of July 2020. Still a work in progress
Hochgeladen 2020-07-11 10:31:34.0
Einsender user's avatar Regina McAnally
E-Mail rmcana64@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Kommentare

Ansichten für diese Person