Gerald Kunzy CLARK

Gerald Kunzy CLARK

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Gerald Kunzy CLARK [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 28. Juni 1913 Binghamton, New York nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Geburt 28. Juni 1913 New York nach diesem Ort suchen
Tod 5. Februar 1989 Orleans County, New York, USA nach diesem Ort suchen [21] [22]
Tod 5. Februar 1989
Heirat 10. Oktober 1936 Brockport, New York, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1. Juni 1925 Fenton, Broome, New York, United States nach diesem Ort suchen [23]
Wohnen 1951 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Before 1951") New York nach diesem Ort suchen [24]
Wohnen Brockport, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [25]
Wohnen 1930 Penfield, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [26]
Wohnen 1920 Rochester Ward 23, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [27]
Wohnen 1. Juni 1915 Triangle, Broome, New York, United States nach diesem Ort suchen [28]
Wohnen 1935 Brockport, Monroe, New York nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1940 Brockport, Monroe, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]
Marriage 10. Oktober 1936 Brockport, New York, USA nach diesem Ort suchen [31]
Gerald shotgun incident 1961 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1961-07-22") Rochester, New York nach diesem Ort suchen [32]
Gerald Clark Sentenced 4. Oktober 1941 Rochester, New York nach diesem Ort suchen [33]
Gerald death 1989 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1989-02-07") Rochester, New York nach diesem Ort suchen [34]
Gerald Death 1989 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1989-02-06") Rochester, New York nach diesem Ort suchen [35]
G Clark obit 1989 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1989-02-07") Rochester, New York nach diesem Ort suchen [36]
Sentencing 1941 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1941-10-04") Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [37]
troubles 1941 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1941-09-03") Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [38]
obit 1989 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1989-02-07") Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [39]
Parma Fire 1989 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "1989-02-06") Rochester, Monroe, New York, United States of America nach diesem Ort suchen [40]
Heirat 10. Oktober 1936 Brockport, New York, USA nach diesem Ort suchen [41]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Audrey M WALKER
Heirat Ehepartner Kinder
10. Oktober 1936
Brockport, New York, USA
Helen I. WEED

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 61A; Enumeration District: 28-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Triangle; County: Broome; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 23, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 6B; Enumeration District: 264
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Penfield, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0237; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Fenton; County: Broome; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Democrat and Chronicle; Publication Date: 24/ Jan/ 1976; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136921137/?article=007c8d04-f394-4454-9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Democrat and Chronicle; Publication Date: 16/ Apr/ 1967; Publication Place: Rochester, New York, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/136565131/?article=75b6bbc8-6ee8-45ed-9
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
13 Ohio, Death Records, 1908-1932, 1938-2018
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 61A; Enumeration District: 28-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Triangle; County: Broome; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 23, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 6B; Enumeration District: 264
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Penfield, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0237; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Fenton; County: Broome; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 Ohio, Death Records, 1908-1932, 1938-2018
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 New York, State Census, 1925, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1925; Election District: 02; Assembly District: 01; City: Fenton; County: Broome; Page: 4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Social Security Death Index, 1935-2014, Social Security Administration; Washington D.C., USA; Social Security Death Index, Master File
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Penfield, Monroe, New York; Page: 3B; Enumeration District: 0237; FHL microfilm: 2341182
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Rochester Ward 23, Monroe, New York; Roll: T625_1125; Page: 6B; Enumeration District: 264
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 03; Assembly District: 01; City: Triangle; County: Broome; Page: 05
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 61A; Enumeration District: 28-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Brockport, Monroe, New York; Roll: m-t0627-02680; Page: 61A; Enumeration District: 28-90
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Ancestry Family Trees, Cited in the family tree "myroyalfamily" created by "monkeyluv"
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
32 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1961-07-22 - Page 20, Gerald2 1961-07-22
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
33 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 4 Oct 1941 - Page 14, 4 Oct 1941
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
34 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1989-02-07 - Page Page 4, Gerald death 1989-02-07
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
35 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1989-02-06 - Page Page 57, Gerald Death 1989-02-06
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
36 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1989-02-07 - Page Page 16, G Clark obit 1989-02-07
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
37 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1941-10-04 - Page Page 14, 1941-10-04
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
38 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1941-09-03 - Page Page 15, 1941-09-03
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
39 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1989-02-07 - Page Page 16, 1989-02-07
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
40 Newspapers.com - Democrat and Chronicle - 1989-02-06 - Page Page 57, 1989-02-06
Angaben zur Veröffentlichung: Democrat and Chronicle
41 New York State, Marriage Index, 1881-1967, New York State Department of Health; Albany, NY, USA; New York State Marriage Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kern Family Tree
Beschreibung
Hochgeladen 2021-02-07 06:04:32.0
Einsender user's avatar Patricia Kern
E-Mail trckern@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person