Kate BÄHR
♀ Kate BÄHR
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Kate BÄHR | [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | etwa 1861 | Kentucky nach diesem Ort suchen | [12] [13] [14] [15] [16] [17] |
Wohnen | 1870 | Louisville Ward 11, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [18] |
Wohnen | 1880 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [19] |
Wohnen | 1900 | Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [20] |
Wohnen | 1920 | Cheerokee, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [21] |
Wohnen | 1932 | Louisville, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [22] |
Wohnen | 1935 | Louisville, Jefferson, Kentucky nach diesem Ort suchen | [23] |
Wohnen | 1940 | Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [24] |
Arrival | 29. Oktober 1883 | New York, New York, USA nach diesem Ort suchen | [25] |
Departure | Antwerp, Belgium nach diesem Ort suchen | [26] | |
Heirat | 31. Januar 1889 | Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen | [27] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
31. Januar 1889 Jefferson, Kentucky, USA |
Levi Henrich SPAHN |
|
Quellenangaben
1 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. |
2 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
3 | Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1883; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 22; List Number: 1372 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
5 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 4; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1240529 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | Kentucky, County Marriage Records, 1783-1965 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
8 | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Courier-Journal; Publication Date: 15/ May/ 1933; Publication Place: Louisville, Kentucky, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/107738927/?article=4c954187-f069-4540-98d8-4814dd308108&focus=0.7366334,0.08600529,0.8548 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
9 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cheerokee, Jefferson, Kentucky; Roll: T625_577; Page: 6B; Enumeration District: 10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
10 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 1B; Enumeration District: 121-314B Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
11 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 11, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_476; Page: 506A; Family History Library Film: 545975 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
13 | New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1883; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 22; List Number: 1372 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 4; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1240529 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
15 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cheerokee, Jefferson, Kentucky; Roll: T625_577; Page: 6B; Enumeration District: 10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
16 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 1B; Enumeration District: 121-314B Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
17 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 11, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_476; Page: 506A; Family History Library Film: 545975 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
18 | 1870 United States Federal Census, Year: 1870; Census Place: Louisville Ward 11, Jefferson, Kentucky; Roll: M593_476; Page: 506A; Family History Library Film: 545975 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
20 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 4; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1240529 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
21 | 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Cheerokee, Jefferson, Kentucky; Roll: T625_577; Page: 6B; Enumeration District: 10 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
22 | U.S. City Directories, 1822-1995 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
23 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 1B; Enumeration District: 121-314B Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
24 | 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 1B; Enumeration District: 121-314B Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
25 | New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1883; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 22; List Number: 1372 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
26 | New York, Passagier- und Besatzungslisten (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1883; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 22; List Number: 1372 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
27 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 3, Jefferson, Kentucky; Page: 4; Enumeration District: 0033; FHL microfilm: 1240529 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Ahnen |
Beschreibung | Für Ergänzungen und Berichtigungen bin ich sehr dankbar. Bitte unter: rebecca.mert@gmx.de |
Hochgeladen | 2023-12-17 17:49:22.0 |
Einsender | Rebecca Mert |
rebecca.mert@gmx.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |