Jacob BÄHR

Jacob BÄHR

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Jacob BÄHR [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Dezember 1864 Kentucky, United States of America nach diesem Ort suchen [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Bestattung Louisville, Jefferson County, Kentucky, United States of America nach diesem Ort suchen [24]
Tod 9. Mai 1953 Louisville, Jefferson County, Kentucky, United States of America nach diesem Ort suchen [25] [26] [27] [28]
Wohnen 1880 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Wohnen 1900 Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [30]
Wohnen 1910 Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [31]
Wohnen 1930 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1935 Louisville, Jefferson, Kentucky nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1936 Louisville, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1940 Louisville, Jefferson, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 2725 Virginia Ave. nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen Jefferson nach diesem Ort suchen [37]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Page: 3B; Enumeration District: 0156; FHL microfilm: 2340494
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Roll: T624_486; Page: 9B; Enumeration District: 0148; FHL microfilm: 1374499
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 5A; Enumeration District: 121-304
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Page: 621; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 1240531
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Courier-Journal; Publication Date: 12/ May/ 1953; Publication Place: Louisville, Kentucky, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/108494981/?article=f6d6e1f7-e063-4941-8dff-69bf19b759e2&focus=0.025881143,0.5928016,0.136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 USA, Transportdienst der Armee, Passagierlisten, 1910-1939, The National Archives at College Park; College Park, Maryland; Record Group Title: Records of the Office of the Quartermaster General, 1774-1985; Record Group Number: 92; Roll or Box Number: 520
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Page: 3B; Enumeration District: 0156; FHL microfilm: 2340494
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Roll: T624_486; Page: 9B; Enumeration District: 0148; FHL microfilm: 1374499
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 5A; Enumeration District: 121-304
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Page: 621; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 1240531
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Courier-Journal; Publication Date: 12/ May/ 1953; Publication Place: Louisville, Kentucky, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/108494981/?article=f6d6e1f7-e063-4941-8dff-69bf19b759e2&focus=0.025881143,0.5928016,0.136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 Kentucky, Death Records, 1852-1965, Kentucky Department for Libraries and Archives; Frankfort, Kentucky
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Courier-Journal; Publication Date: 12/ May/ 1953; Publication Place: Louisville, Kentucky, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/108494981/?article=f6d6e1f7-e063-4941-8dff-69bf19b759e2&focus=0.025881143,0.5928016,0.136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: 422; Page: 19A; Enumeration District: 108
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Page: 621; Enumeration District: 0080; FHL microfilm: 1240531
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Louisville Ward 9, Jefferson, Kentucky; Roll: T624_486; Page: 9B; Enumeration District: 0148; FHL microfilm: 1374499
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Page: 3B; Enumeration District: 0156; FHL microfilm: 2340494
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
33 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 5A; Enumeration District: 121-304
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Louisville, Jefferson, Kentucky; Roll: m-t0627-01375; Page: 5A; Enumeration District: 121-304
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Courier-Journal; Publication Date: 12/ May/ 1953; Publication Place: Louisville, Kentucky, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/108494981/?article=f6d6e1f7-e063-4941-8dff-69bf19b759e2&focus=0.025881143,0.5928016,0.136
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Kentucky, Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Ahnen
Beschreibung Für Ergänzungen und Berichtigungen bin ich sehr dankbar. Bitte unter: rebecca.mert@gmx.de
Hochgeladen 2023-12-17 17:49:22.0
Einsender user's avatar Rebecca Mert
E-Mail rebecca.mert@gmx.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person