Johann Jakob KAISER

Johann Jakob KAISER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Johann Jakob KAISER [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Name Engelbert Leonhard KAFADER [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Name Engelbert KAFADER [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 21. November 1832 Leuzigen, Bern, Schweiz nach diesem Ort suchen [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]
Geburt 9. Februar 1836 Laachen Switzerland nach diesem Ort suchen [42] [43] [44]
Geburt 17. Februar 1835 Laachen, Switzerland nach diesem Ort suchen [45]
Geburt 17. Februar 1836 Switzerland nach diesem Ort suchen [46] [47] [48] [49] [50]
Geburt 9. Februar 1836 Lachen, Schwyz, Schweiz nach diesem Ort suchen
Geburt 17. Februar 1835 Lachen, Schwyz, Schweiz nach diesem Ort suchen
Bestattung Terre Haute, Vigo County, Indiana, United States of America nach diesem Ort suchen [51]
Tod 4. Mai 1876 New Philadelphia, Tuscarawas, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [52] [53] [54] [55] [56] [57]
Tod 16. Januar 1917 Terre Haute, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [58] [59] [60] [61] [62]
Tod 1917 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "January 16, 1917") Terre Haute, Vigo County, Indiana nach diesem Ort suchen [63] [64]
Wohnen 1878 Terre Haute, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [65]
Wohnen 1880 Terre Haute, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [66]
Wohnen 1880 Terre Haute, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [67]
Wohnen 1890 Terre Haute, IN nach diesem Ort suchen [68]
Wohnen 1892 Terre Haute, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [69]
Wohnen 1900 Harrison, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [70]
Wohnen 1900 Harrison, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [71]
Wohnen 1901 Terre Haute, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [72]
Wohnen 1910 Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [73]
Wohnen 1910 Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana, USA nach diesem Ort suchen [74]
Arrival 1873 [75] [76]
Arrival 11. Dezember 1878 New York, New York nach diesem Ort suchen [77]
Arrival 11. Dezember 1878 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [78]
Arrival 19. August 1887 New York, New York nach diesem Ort suchen [79]
Departure Hamburg, Germany and Le Havre, France nach diesem Ort suchen [80]
Departure Rotterdam, Netherlands nach diesem Ort suchen [81]
Heirat 30. September 1853 Attiswil, Solothurn, Switzerland nach diesem Ort suchen
Heirat 1857 [82]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
30. September 1853
Attiswil, Solothurn, Switzerland
Anna Maria GUEGELMANN

Quellenangaben

1 Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree
Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.
2 Passagierschiffe und Bilder
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 Indiana, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Terre Haute, Vigo, Indiana; Roll: 318; Page: 348D; Enumeration District: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 Indiana, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Verzeichnisse für Terre Haute, Indiana, 1890, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 415; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1916; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 Föderale US-Volkszählung 1900, Year: 1900; Census Place: Harrison, Vigo, Indiana; Page: 5; Enumeration District: 0121; FHL microfilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Todesfälle in Indiana, 1882–1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 New York, Passagierlisten, 1820-1957, Year: 1887; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 510; Line: 31; List Number: 1055
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Verzeichnisse für Terre Haute, Indiana, 1890, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Indiana, USA, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Terre Haute, Vigo, Indiana; Roll: 318; Page: 348D; Enumeration District: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
24 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Indiana, USA, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Indiana, USA, WPA-Sterbeindex, 1882-1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 Indiana, USA, Sterbeurkunden, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
31 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Terre Haute, Vigo, Indiana; Roll: 318; Page: 348D; Enumeration District: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
34 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
35 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 415; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Föderale US-Volkszählung 1900, Year: 1900; Census Place: Harrison, Vigo, Indiana; Page: 5; Enumeration District: 0121; FHL microfilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 Todesfälle in Indiana, 1882–1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 New York, Passagierlisten, 1820-1957, Year: 1887; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 510; Line: 31; List Number: 1055
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
42 US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Terre Haute, Vigo, Indiana; Roll: 318; Page: 348D; Enumeration District: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
45 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
46 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 Indiana, USA, WPA-Sterbeindex, 1882-1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
49 Indiana, USA, Sterbeurkunden, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
50 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
51 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
52 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 Indiana, USA, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 Indiana, USA, WPA-Sterbeindex, 1882-1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
55 Indiana, USA, Sterbeurkunden, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
56 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
57 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
58 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1917; Roll: 20
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
59 Indiana, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
60 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
61 Web: Wabash Valley, Indiana, Todesanzeigenindex, 1900-2013
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
62 Todesfälle in Indiana, 1882–1920
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
63 Indiana, USA, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1798-1999, Will Records, 1818-1921; Author: Indiana. Circuit Court (Vigo County); Vigo County (Indiana). Clerk of the Circuit Court; Probate Place: Vigo, Indiana
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
64 USA, Find A Grave-Index, 1600-heute
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
65 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
66 US-Volkszählung 1880, Year: 1880; Census Place: Terre Haute, Vigo, Indiana; Roll: 318; Page: 348D; Enumeration District: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
67 US-Volkszählung 1880, Jahr: 1880; Gebiet der Volkszählung: Terre Haute, Vigo, Indiana; Rolle: 318; Seite: 348D; Zählungsdistrikt: 209
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
68 Verzeichnisse für Terre Haute, Indiana, 1890, 1892
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
69 USA-Städteverzeichnisse, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
70 Föderale US-Volkszählung 1900, Year: 1900; Census Place: Harrison, Vigo, Indiana; Page: 5; Enumeration District: 0121; FHL microfilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
71 1900 United States Federal Census, Jahr: 1900; Gebiet der Volkszählung: Harrison, Vigo, Indiana; Seite: 5; Zählungsdistrikt: 0121; FHL-Mikrofilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
72 U.S. City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
73 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
74 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
75 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Terre Haute Ward 5, Vigo, Indiana; Roll: T624_385; Page: 14B; Enumeration District: 0161; FHL microfilm: 1374398
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
76 Föderale US-Volkszählung 1900, Year: 1900; Census Place: Harrison, Vigo, Indiana; Page: 5; Enumeration District: 0121; FHL microfilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
77 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 415; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
78 New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
79 New York, Passagierlisten, 1820-1957, Year: 1887; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 510; Line: 31; List Number: 1055
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
80 New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1878; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 415; Line: 11; List Number: 1302
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
81 New York, Passagierlisten, 1820-1957, Year: 1887; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 510; Line: 31; List Number: 1055
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
82 Föderale US-Volkszählung 1900, Year: 1900; Census Place: Harrison, Vigo, Indiana; Page: 5; Enumeration District: 0121; FHL microfilm: 1240409
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Häring 2023
Beschreibung
Hochgeladen 2023-03-19 21:23:13.0
Einsender user's avatar André Häring
E-Mail andre.haering@bluewin.ch
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person