Myra Elizabeth AMES

Myra Elizabeth AMES

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Myra Elizabeth AMES [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. Januar 1858 Boone County, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
Bestattung 1915 Linden Grove Cemetery, Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [33]
Tod 30. September 1915 Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34] [35] [36] [37]
Wohnen 1860 Walton, Boone, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1878 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [39]
Wohnen 1880 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [40]
Wohnen 1900 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [41]
Wohnen 1910 Covington, Kenton, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [42]
FamilySearch ID
MaidenName [43]
Heirat 1907 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1888–1907")
Heirat 1891 [44] [45]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
1907 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1888–1907")
David A. WILLIAMS

Quellenangaben

1 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Walton, Boone, Kentucky; Roll: M653_355; Page: 443; Family History Library Film: 803355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 10A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1957; Roll: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1957; Roll: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 One World Tree
14 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Walton, Boone, Kentucky; Roll: M653_355; Page: 443; Family History Library Film: 803355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 10A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1957; Roll: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1957; Roll: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 One World Tree
24 Kentucky, U.S., Birth Records, 1847-1911
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Walton, Boone, Kentucky; Roll: M653_355; Page: 443; Family History Library Film: 803355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 10A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 One World Tree
33 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 Kentucky, U.S., Death Records, 1852-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 One World Tree
38 1860 United States Federal Census, Year: 1860; Census Place: Walton, Boone, Kentucky; Roll: M653_355; Page: 443; Family History Library Film: 803355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 1880 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
41 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: T624_488; Page: 10A; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1374501
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1957; Roll: 12
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
44 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Covington , Kenton, Kentucky; Roll: 534; Page: 8; Enumeration District: 0090; FHL microfilm: 1240534
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person