Mathew Chester KOVERMAN

Mathew Chester KOVERMAN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Mathew Chester KOVERMAN [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
Beruf Mechanic Automobile 1910 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen
Beruf Proprietor Central Auto Station (r 238 Main h 620 E Main), New Britain, Hartford, CT 1923
Beruf 1927 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen
Beruf Mechanic Auto Repair 1930
Beruf 1938 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1931–1938") New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 25. August 1875 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]
Tod 30. Oktober 1949 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [52] [53] [54] [55] [56]
Wohnen 1880 Dinsmore, Shelby, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [57] [58] [59]
Wohnen 1900 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [60] [61]
Wohnen 1910 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [62]
Wohnen 1917 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [63] [64] [65] [66] [67]
Wohnen 1920 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [68] [69]
Wohnen 1930 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [70] [71]
Wohnen 1935 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [72]
Wohnen 1. April 1940 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [73]
Wohnen 1948 (ermittelt aus der ursprünglichen Angabe "Bet. 1946–1948") New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen
Wohnen 1949 New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [74]
Build
Color of Eyes
Color of Hair
FamilySearch ID
Other-Begin New Britain, Hartford, Connecticut, USA nach diesem Ort suchen [75]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 Connecticut, Military Census, 1917
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: T627_504; Page: 2A; Enumeration District: 2-125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Connecticut Death Index, 1949-2012, Database online.
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 6, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 9B; Enumeration District: 175; Image: 1091
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Database online. Year: 1930; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 198; Image: 439.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1880 United States Federal Census, Database online. Year: 1880; Census Place: Dinsmore, Shelby, Ohio; Roll: 1066; Family History Film: 1255066; Page: 91D; Enumeration District: 209; Image: 0284.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 139; Page: 1A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 1240139
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
10 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Hartford Courant; Publication Date: 30 Oct 1899; Publication Place: Hartford, Connecticut, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/369231855/?article=f0f10f15-dcd9-4bee-b3ff-b97e9e0b860e&focus=0.045425683,0.51336175,0.186631
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 WEB: Connecticut Death Records, 1897-1968, State Vital Records Office; Hartford, Connecticut; Connecticut Vital Records — Index of Deaths, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
15 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
16 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
17 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
20 Connecticut, Military Census, 1917
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: T627_504; Page: 2A; Enumeration District: 2-125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Connecticut Death Index, 1949-2012, Database online.
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 6, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 9B; Enumeration District: 175; Image: 1091
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1930 United States Federal Census, Database online. Year: 1930; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 198; Image: 439.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 1880 United States Federal Census, Database online. Year: 1880; Census Place: Dinsmore, Shelby, Ohio; Roll: 1066; Family History Film: 1255066; Page: 91D; Enumeration District: 209; Image: 0284.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
27 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 139; Page: 1A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 1240139
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
29 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, Hartford Courant; Publication Date: 30 Oct 1899; Publication Place: Hartford, Connecticut, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/369231855/?article=f0f10f15-dcd9-4bee-b3ff-b97e9e0b860e&focus=0.045425683,0.51336175,0.186631
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 WEB: Connecticut Marriage Records, 1897-1968, Connecticut State Department of Health; Hartford, CT; Connecticut Vital Records — Index of Marriages, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 WEB: Connecticut Death Records, 1897-1968, State Vital Records Office; Hartford, Connecticut; Connecticut Vital Records — Index of Deaths, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
34 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
35 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 Connecticut, Military Census, 1917
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: T627_504; Page: 2A; Enumeration District: 2-125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
40 Connecticut Death Index, 1949-2012, Database online.
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 6, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 9B; Enumeration District: 175; Image: 1091
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 1930 United States Federal Census, Database online. Year: 1930; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 198; Image: 439.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
43 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
44 1880 United States Federal Census, Database online. Year: 1880; Census Place: Dinsmore, Shelby, Ohio; Roll: 1066; Family History Film: 1255066; Page: 91D; Enumeration District: 209; Image: 0284.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
45 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 139; Page: 1A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 1240139
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
46 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
47 U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
48 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
49 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
50 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
51 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
52 Connecticut Death Index, 1949-2012, Database online.
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
53 WEB: Connecticut Death Records, 1897-1968, State Vital Records Office; Hartford, Connecticut; Connecticut Vital Records — Index of Deaths, 1897-1968
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
54 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
55 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
56 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
57 1880 United States Federal Census, Database online. Year: 1880; Census Place: Dinsmore, Shelby, Ohio; Roll: 1066; Family History Film: 1255066; Page: 91D; Enumeration District: 209; Image: 0284.
Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
58 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
59 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
60 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 139; Page: 1A; Enumeration District: 0213; FHL microfilm: 1240139
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
61 1900 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
62 1910 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
63 Connecticut, Military Census, 1917
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
64 Connecticut Death Index, 1949-2012, Database online.
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
65 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
66 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
67 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
68 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: New Britain Ward 6, Hartford, Connecticut; Roll: T625_185; Page: 9B; Enumeration District: 175; Image: 1091
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
69 1920 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
70 1930 United States Federal Census, Database online. Year: 1930; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: 267; Page: 1B; Enumeration District: 198; Image: 439.0.
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
71 1930 United States Federal Census
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
72 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: T627_504; Page: 2A; Enumeration District: 2-125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
73 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: New Britain, Hartford, Connecticut; Roll: T627_504; Page: 2A; Enumeration District: 2-125
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
74 Connecticut Death Index, 1949-2001
Autor: Connecticut Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Provo, UT: MyFamily.com, Inc., 2003
75 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person