Freeda STAPLETON

Freeda STAPLETON

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Freeda STAPLETON [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 1. April 1916 Elliott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
Bestattung 1985 Collier Memorial Gardens, South Portsmouth, Greenup, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29]
Tod 19. Januar 1985 Portsmouth, Scioto, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [30] [31] [32] [33]
Wohnen 1920 Little Fork, Elliott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1930 District 2, District 2, Elliott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1935 Elliott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1940 Magisterial Dist No 2, Elliott, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Wohnen 1950 Greenup, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [38]
Wohnen 1959 Aurora, DuPage, Illinois, USA nach diesem Ort suchen [39]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder

Quellenangaben

1 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Paintsville, Johnson, Kentucky; Roll: m-t0627-01322; Page: 5B; Enumeration District: 58-1B
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Elliott, Kentucky; Roll: m-t0627-01300; Page: 9A; Enumeration District: 32-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
4 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Little Fork, Elliott, Kentucky; Roll: T625_567; Page: 6A; Enumeration District: 76
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 2, Elliott, Kentucky; Page: 19A; Enumeration District: 0004; FHL microfilm: 2340476
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
8 Kentucky, Birth Index, 1911-1999
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
9 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Greenup, Ken
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
12 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Elliott, Kentucky; Roll: m-t0627-01300; Page: 9A; Enumeration District: 32-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Little Fork, Elliott, Kentucky; Roll: T625_567; Page: 6A; Enumeration District: 76
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 Kentucky, Birth Index, 1911-1999
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Greenup, Ken
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Elliott, Kentucky; Roll: m-t0627-01300; Page: 9A; Enumeration District: 32-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Little Fork, Elliott, Kentucky; Roll: T625_567; Page: 6A; Enumeration District: 76
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Kentucky, Birth Index, 1911-1999
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Greenup, Ken
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
30 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Ohio Department of Health; Columbus, Ohio; Ohio Deaths, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007
Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
32 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Little Fork, Elliott, Kentucky; Roll: T625_567; Page: 6A; Enumeration District: 76
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: District 2, Elliott, Kentucky; Page: 19A; Enumeration District: 0004; FHL microfilm: 2340476
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
36 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Elliott, Kentucky; Roll: m-t0627-01300; Page: 9A; Enumeration District: 32-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
37 1940 United States Federal Census, Year: 1940; Census Place: Elliott, Kentucky; Roll: m-t0627-01300; Page: 9A; Enumeration District: 32-4
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
38 1950 United States Federal Census, United States of America, Bureau of the Census; Washington, D.C.; Seventeenth Census of the United States, 1950; Record Group: Records of the Bureau of the Census, 1790-2007; Record Group Number: 29; Residence Date: 1950; Home in 1950: Greenup, Ken
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
39 U.S. City Directories, 1821-1989
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person