Reinhart JAEGER

Reinhart JAEGER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Reinhart JAEGER [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Taufe 24. Januar 1869 Katholisch, Ichenheim, Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Germany nach diesem Ort suchen [20]
Geburt 14. Januar 1869 Katholisch, Ichenheim, Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Germany nach diesem Ort suchen [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
Bestattung 1938 Saint Stephen Cemetery, Fort Thomas, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [28]
Tod 21. Dezember 1938 Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [29] [30] [31]
Heirat 22. Juni 1914 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [32]
Wohnen 1869 Ichenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Germany nach diesem Ort suchen [33]
Wohnen 1920 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [34]
Wohnen 1923 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [35]
Wohnen 1930 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [36]
Wohnen 1938 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [37]
Arrival 1892 [38] [39]
Heirat 31. Juli 1895 Hamilton County, Ohio, USA nach diesem Ort suchen [40] [41] [42]
Heirat 22. Juni 1914 Newport, Campbell, Kentucky, USA nach diesem Ort suchen [43]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
31. Juli 1895
Hamilton County, Ohio, USA
Ida J GEIMAN

Quellenangaben

1 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
2 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
3 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
5 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
6 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
7 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Kentucky Post; Publication Date: 27 Jul 1943; Publication Place: Covington, Kentucky, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/760819247/?article=24e2982d-f506-4b64-a55e-f2a4606f85d1&focus=0.37633893,0.22063066,0.49641308,0.24927263&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
11 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
14 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
15 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
16 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
17 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
18 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
19 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
21 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
22 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
25 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
28 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 Kentucky, Death Records, 1852-1953
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
31 U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
32 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
33 Germany, Select Births and Baptisms, 1558-1898
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
34 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
35 U.S., City Directories, 1822-1995
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
36 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
37 Kentucky Death Index, 1911-2000
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
38 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Newport Ward 5, Campbell, Kentucky; Roll: T625_563; Page: 4B; Enumeration District: 31; Image: 1059
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
39 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Newport, Campbell, Kentucky; Roll: 737; Page: 23A; Enumeration District: 9; Image: 1002.0; FHL microfilm: 2340472
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
40 Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
41 U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, The Kentucky Post; Publication Date: 27 Jul 1943; Publication Place: Covington, Kentucky, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/760819247/?article=24e2982d-f506-4b64-a55e-f2a4606f85d1&focus=0.37633893,0.22063066,0.49641308,0.24927263&xid=3355
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
42 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
43 Kentucky, U.S., County Marriage Records, 1783-1965
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person