Anna SIERP

Anna SIERP

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Anna SIERP [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt etwa 1889 Germany nach diesem Ort suchen [16] [17] [18] [19]
Wohnen 1910 Manhattan, Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [20]
Wohnen 1. Juni 1915 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [21]
Wohnen 1920 Raritan, Hunterdon, New Jersey, USA nach diesem Ort suchen [22]
Arrival 1906 [23]
Arrival 1. Mai 1907 New York, New York, USA nach diesem Ort suchen [24] [25]
Departure vor 1. Mai 1907 Antwerpen, Antwerpen, Belgium nach diesem Ort suchen [26]
Race [27]
Race [28] [29]
Heirat 3. Oktober 1918 Kings, New York, USA nach diesem Ort suchen [30]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
3. Oktober 1918
Kings, New York, USA
Conrad LIEDEL

Quellenangaben

1 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 15; Assembly District: 12; City: New York; County: New York; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
2 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Raritan, Hunterdon, New Jersey; Roll: T625_1051; Page: 9A; Enumeration District: 23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
3 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
4 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 8; Page Number: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
5 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 6; Page Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
6 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
7 New York, New York, U.S., Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
8 New York, New York, U.S., Marriage License Indexes, 1907-2018, New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Brooklyn
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
9 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
10 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 15; Assembly District: 12; City: New York; County: New York; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
11 U.S., World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
12 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 6; Page Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
13 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
14 New York, New York, U.S., Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
15 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
16 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 15; Assembly District: 12; City: New York; County: New York; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
17 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 6; Page Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
18 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
19 Geneanet Community Trees Index
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
20 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
21 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 15; Assembly District: 12; City: New York; County: New York; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
22 1920 United States Federal Census, Year: 1920; Census Place: Raritan, Hunterdon, New Jersey; Roll: T625_1051; Page: 9A; Enumeration District: 23
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
23 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
24 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 8; Page Number: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
25 New York, Passenger Lists, 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 6; Page Number: 106
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
26 New York, U.S., Arriving Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1907; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 8; Page Number: 66
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
27 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
28 New York, State Census, 1915, New York State Archives; Albany, New York; State Population Census Schedules, 1915; Election District: 15; Assembly District: 12; City: New York; County: New York; Page: 39
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.
29 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Manhattan , New York, New York; Roll: T624_1035; Page: 11A; Enumeration District: 0940; FHL microfilm: 1375048
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc
30 New York, New York, U.S., Extracted Marriage Index, 1866-1937
Autor: Ancestry.com
Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc.

Datenbank

Titel Kovermann 2024-03-30
Beschreibung
Hochgeladen 2024-03-30 18:22:21.0
Einsender user's avatar Andreas Kovermann
E-Mail kovermann@freenet.de
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person